UID-Suche.at

UID-Suche


Alle Informationen zu:

                        
Name

Giacom (Distribution) Limited

Adresse
Milton Gate
60 Chiswell Street
London
EC1Y 4AG
VAT ID (UID-Nummer) keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer 02114602 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschlussfull
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)61200 - Drahtlose Telekommunikation
FB Statusactive
Vorherige Namen
  • Anglia Telecom Centres Limited
  • KYC Check
    KYC / PEP / AML-Abfrage
    Diese Daten sind inkorrekt?
    Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

    Schnellzugriff

    Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

    Quelle: Companies House
    gb-flag GB Giacom Limited Status: Aktiv Eintragung: 12.03.2021 Companies House Nummer: 13078299 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Daisy Intermediate Holdings Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 12.07.2019 Companies House Nummer: 08384981 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Digital Wholesale Solutions Holdings Limited Status: Inaktiv Eintragung: 12.07.2019 Löschung: 12.03.2021 Companies House Nummer: 11698405 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • Officers (8)

    Quelle: Companies House
    Boland, Andrew Kenneth London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 03.11.2021 Geburtsdatum: 12.1969 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Marke, Nathan Richard London, United Kingdom, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 27.02.2015 Geburtsdatum: 02.1970 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    O'Brien, Terence John London, United Kingdom, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.02.2019 Geburtsdatum: 08.1974 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Righton, Timothy Paul London, United Kingdom, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.02.2019 Geburtsdatum: 05.1983 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Brewer, Ian David, Mr. Bellingdon, Chesham Status: Inaktiv Eintragung: 29.04.2005 Löschung: 18.07.2006 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Dubens, Peter Adam Daiches London Status: Inaktiv Eintragung: 28.08.2009 Löschung: 20.10.2011 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Switzerland Nationalität: British
    Spink, Geoffrey Clandon Road, West Clandon, Guildford Status: Inaktiv Eintragung: 19.04.2005 Löschung: 29.04.2005 Beschäftigung: Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Synett, Jacob Julian Pinnacle Place, Green Lane, Stanmore Status: Inaktiv Eintragung: 01.02.2004 Löschung: 29.04.2005 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

    Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)

    gb-flag GB Spiritel Mobile Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 12.07.2019 Companies House Nummer: 04232789 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Voice Holdings Limited Status: Inaktiv Eintragung: 15.06.2018 Löschung: 12.07.2019 Companies House Nummer: 04119078 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors