UID-Suche.at

UID-Suche


Alle Informationen zu:

                        
Name

Denholm Good Logistics Limited

Adresse
2nd Floor 5 St Paul's Squar
Old Hall Street
Liverpool
L3 9SJ
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
Beginn der Umsatzsteuer Registrierung
13. Mai 2016
Firmenbuch-Nummer 01607606 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschlussfull
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)52290 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für den Verkehr a. n. g.
FB Statusactive
Vorherige Namen
  • John Good Shipping LTD
  • John Good Logistics Limited
  • John Good & Sons (Shipping) Limited
  • KYC Check
    KYC / PEP / AML-Abfrage
    Diese Daten sind inkorrekt?
    Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

    Schnellzugriff

    Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

    Quelle: Companies House
    gb-flag GB J.&J. Denholm Limited Status: Aktiv Eintragung: 31.08.2021 Companies House Nummer: 00955037 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Good, John Ambrose Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 07.02.2018 Geburtsdatum: 07.1939 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • gb-flag GB John Good & Sons Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 31.08.2021 Companies House Nummer: 00096398 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • Officers (14)

    Quelle: Companies House
    Daniels, Craig David George Glasgow, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 31.08.2021 Rolle: Secretary
    Hall, Kieran Joseph Old Hall Street, Liverpool, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 31.08.2021 Geburtsdatum: 03.1955 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Jennings, James Gerard Old Hall Street, Liverpool, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.04.2007 Geburtsdatum: 01.1964 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Maclehose, Benjamin Donald Robert 12 Finsbury Square, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 31.08.2021 Geburtsdatum: 02.1981 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Parkinson, David Old Hall Street, Liverpool, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.01.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Platt, Alan Oliver Old Hall Street, Liverpool, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 23.01.2003 Geburtsdatum: 11.1969 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Rutherford, John David Old Hall Street, Liverpool, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 31.08.2021 Geburtsdatum: 10.1951 Beschäftigung: Non-Executive Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Ferguson, Paul Scott Ian Old Hall Street, Liverpool, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 01.01.2016 Löschung: 01.01.2024 Geburtsdatum: 05.1978 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Fitzgerald, Peter James Old Hall Street, Liverpool, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 01.01.2016 Löschung: 01.01.2024 Geburtsdatum: 07.1974 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Garnier, Jonathan Ramon Old Hall Street, Liverpool, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 17.03.2008 Löschung: 01.01.2024 Geburtsdatum: 05.1968 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Gosling, Stuart Charles Old Hall Street, Liverpool, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 01.11.2016 Löschung: 01.01.2024 Geburtsdatum: 09.1963 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Mcmahon, Michael Gerard Old Hall Street, Liverpool, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 31.08.2021 Löschung: 31.08.2023 Geburtsdatum: 05.1962 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Preston, Simon Luke Glasgow, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 31.08.2021 Löschung: 01.01.2024 Geburtsdatum: 10.1980 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Scotland Nationalität: British
    Wallace, Steven David James Glasgow, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 14.09.2023 Löschung: 01.01.2024 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

    Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (9)

    gb-flag GB CBI Transportation UK Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 04652909 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Denholm Global Logistics Limited Status: Aktiv Eintragung: 04.07.2023 Companies House Nummer: 02922837 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag Inter-Ways LTD Status: Aktiv Eintragung: 31.10.2023 Companies House Nummer: 04991807 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB John Good AIR Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 09927142 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Rewico (UK) Limited Status: Aktiv Eintragung: 31.12.2018 Companies House Nummer: 00688042 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag Transtainer Systems (UK) LTD Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 01052269 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Cougar Freight Services Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 19.08.2021 Companies House Nummer: 01652176 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Felixstowe Warehousing CO. Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 19.08.2021 Companies House Nummer: 05987692 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Focs Logistics Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 19.08.2021 Companies House Nummer: 06698509 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors

  • Branch VAT Numbers (1)

    gb-flag Transtainer Systems (UK) LTD450 High Road, Ilford, Essex, IG1 1UP