UID-Suche.at

UID-Suche


Alle Informationen zu:

                        
Name

Marshall of Cambridge (Holdings) Limited

Adresse
Airport Works
Cambridge
CB5 8RX
VAT ID (UID-Nummer)

Dies ist eine Branch VAT Number, Sie können den Haupteintrag der Branch VAT Number unten finden!
UID Status aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
Beginn der Umsatzsteuer Registrierung
9. Mai 2023
FB Name Marshall of Cambridge (Holdings) Limited
Firmenbuch-Nummer 02051460 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschlussgroup
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)70100 - Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben
FB Statusactive
KYC Check
KYC / PEP / AML-Abfrage
Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

Schnellzugriff



Haupteintrag der Branch VAT Number

gb-flag Marshall of Cambridge Aerospace L TDAirport Works, Cambridge, CB5 8RX

Personen mit signifikanter Kontrolle (6)

Quelle: Companies House
Boscawen, David Simon Townshend Status: Aktiv Eintragung: 04.06.2020 Geburtsdatum: 05.1965 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares 50 to 75 percent as trust
  • Voting rights 50 to 75 percent as trust
  • Right to appoint and remove directors as trust
  • Crompton, John David Status: Aktiv Eintragung: 08.12.2022 Geburtsdatum: 02.1963 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares 50 to 75 percent as trust
  • Voting rights 50 to 75 percent as trust
  • Right to appoint and remove directors as trust
  • Hewitson, Charles Robert Barker Status: Aktiv Eintragung: 27.07.2019 Geburtsdatum: 11.1952 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares 50 to 75 percent as trust
  • Voting rights 50 to 75 percent as trust
  • Right to appoint and remove directors as trust
  • Buxton, Aubrey James Francis Status: Inaktiv Eintragung: 27.07.2019 Löschung: 31.08.2022 Geburtsdatum: 03.1956 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares 50 to 75 percent as trust
  • Voting rights 50 to 75 percent as trust
  • Right to appoint and remove directors as trust
  • Drake, Michael John Status: Inaktiv Eintragung: 27.07.2019 Löschung: 26.05.2021 Geburtsdatum: 08.1950 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares 50 to 75 percent as trust
  • Voting rights 50 to 75 percent as trust
  • Right to appoint and remove directors as trust
  • Marshall, Michael John Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 27.07.2019 Geburtsdatum: 01.1932 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%
  • Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
  • Officers (11)

    Quelle: Companies House
    Baddeley, Julia Margaret Newmarket Road, Cambridge, England Status: Aktiv Eintragung: 01.12.2016 Geburtsdatum: 03.1951 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Buxton, Aubrey James Francis Newmarket Road, Cambridge, England Status: Aktiv Eintragung: 01.04.2014 Geburtsdatum: 03.1956 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Crompton, John David The Airport, Cambridge Status: Aktiv Eintragung: 01.03.2023 Geburtsdatum: 02.1963 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Hardy, Roger Andrew The Airport, Cambridge Status: Aktiv Eintragung: 01.08.2022 Geburtsdatum: 01.1966 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Heaford, David John Newmarket Road, Cambridge, England Status: Aktiv Eintragung: 01.10.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Jenkins, Kathryn Helen Newmarket Road, Cambridge, England Status: Aktiv Eintragung: 05.07.2021 Geburtsdatum: 04.1966 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Moynihan, Sarah Jane Newmarket Road, Cambridge, England Status: Aktiv Eintragung: 30.05.2012 Rolle: Secretary
    Read, Justin Richard Newmarket Road, Cambridge, England Status: Aktiv Eintragung: 01.10.2021 Geburtsdatum: 05.1961 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Shattock, Nicholas Simon Keith Newmarket Road, Cambridge, England Status: Aktiv Eintragung: 01.10.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Baxter, Douglas James The Airport, Cambridge Status: Inaktiv Eintragung: 17.02.2022 Löschung: 15.02.2024 Geburtsdatum: 01.1962 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Flint, David Jonathan Newmarket Road, Cambridge, England Status: Inaktiv Eintragung: 01.03.2019 Löschung: 20.03.2024 Geburtsdatum: 02.1961 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

    Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (10)

    gb-flag GB Cambridge Aero Club Limited(THE) Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 00454656 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • Significant influence or control
  • gb-flag GB Marshall ADG LTD Status: Aktiv Eintragung: 17.01.2017 Companies House Nummer: 10567163 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Marshall ADG LTD Status: Aktiv Eintragung: 17.01.2017 Companies House Nummer: 10567163 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Marshall Fleet Solutions LTD Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 00563027 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • Significant influence or control
  • gb-flag GB Marshall Fleet Solutions LTD Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 00563027 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • Significant influence or control
  • gb-flag Marshall Skills Academy LTD Status: Aktiv Eintragung: 19.04.2023 Companies House Nummer: 14813643 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Marshall of Cambridge (Engineering) Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 00938635 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • Significant influence or control
  • gb-flag GB Mgph Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 01374269 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • Significant influence or control
  • gb-flag GB Marshall Land Systems LTD Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 05.02.2019 Companies House Nummer: 02661432 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Marshall Motor Holdings Limited Status: Inaktiv Eintragung: 24.07.2017 Löschung: 11.05.2022 Companies House Nummer: 02051461 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%
  • Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%
  • Right to appoint and remove directors