UID-Suche.at

UID-Suche


Alle Informationen zu:

                        
Name

Marshall Motor Holdings Limited

Adresse
C/O Marshall Volkswagen Milton Keynes,
Greyfriars Court
Milton Keynes
MK10 0BN
VAT ID (UID-Nummer) keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer 02051461 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschlussgroup
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)70100 - Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben
FB Statusactive
Vorherige Namen
  • Marshall of Cambridge (Motor Holdings) Limited
  • KYC Check
    KYC / PEP / AML-Abfrage
    Diese Daten sind inkorrekt?
    Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

    Schnellzugriff

    Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

    Quelle: Companies House
    gb-flag GB Cag Vega 2 Limited Status: Aktiv Eintragung: 11.05.2022 Companies House Nummer: 13764167 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Marshall Of Cambridge (Holdings) Limited Status: Inaktiv Eintragung: 24.07.2017 Löschung: 11.05.2022 Companies House Nummer: 02051460 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%
  • Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%
  • Right to appoint and remove directors
  • Officers (7)

    Quelle: Companies House
    Casha, Martin Shaun Milton Keynes, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 16.10.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Hemus, Mark Christopher Milton Keynes, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 30.01.2023 Geburtsdatum: 07.1976 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Kelly, Matthew Robert Bartley Way, Hook, Hampshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 11.05.2022 Geburtsdatum: 02.1976 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Letza, Martin Richard Bartley Way, Hook, Hampshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 09.03.2023 Rolle: Secretary
    Mullins, James Anthony Bartley Way, Hook, Hampshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 30.03.2023 Geburtsdatum: 07.1978 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Gupta, Daksh The Airport, Cambridge Status: Inaktiv Eintragung: 01.01.2009 Löschung: 25.05.2022 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Lampert, Timothy Giles Bartley Way, Hook, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 11.05.2022 Löschung: 31.03.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

    Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (10)

    gb-flag GB CMG 2007 Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 06275636 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB CMG 2007 Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 06275636 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Marshall of Ipswich Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 04447940 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Marshall of Scunthorpe Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 01174004 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag Motorline Holdings LTD Status: Aktiv Eintragung: 14.10.2021 Companies House Nummer: 05478773 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag Ridgeway Garages (Newbury) Limited Status: Aktiv Eintragung: 25.05.2016 Companies House Nummer: 03297014 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB S G Smith Holdings Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 09416021 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Silver Street Automotive Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 00716748 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB TIM Brinton Cars Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 01041301 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag Marshall Leasing LTD Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 24.11.2017 Companies House Nummer: 00156897 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors