UID-Suche.at

UID-Suche


Alle Informationen zu:

                        
Name

RES Multas Holdings LTD

Adresse
9 Dunlin Court
3 Teal Close
Enfield
EN3 5TL
VAT ID (UID-Nummer) keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer 12248055 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschlussmicro-entity
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Oktober 2022
Branche (ÖNACE)41100 - Erschließung von Grundstücken; Bauträger
FB Statusactive
KYC Check
KYC / PEP / AML-Abfrage
Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House
gb-flag GB Res Progressio Holdings Limited Status: Aktiv Eintragung: 07.10.2019 Companies House Nummer: 12104685 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • Officers (4)

    Quelle: Companies House
    gb-flag GB Res Progressio Holdings Limited Trinity Place, Midland Drive, Sutton Coldfield, United Kingdom, B72 1TX Status: Aktiv Eintragung: 01.08.2023 Rolle: Corporate-Director Companies House Nummer: 12104685
    Steer, Peter James Midland Drive, Enfield, England Status: Aktiv Eintragung: 01.08.2023 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Beilin, Samuel Midland Drive, Sutton Coldfield, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 23.10.2023 Löschung: 24.10.2023 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Sellman, Nicholas James Midland Drive, Sutton Coldfield, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 07.10.2019 Löschung: 01.08.2023 Geburtsdatum: 01.1981 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

    Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (10)

    gb-flag GB Atlantic House Management LTD Status: Aktiv Eintragung: 08.04.2021 Companies House Nummer: 09995536 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • gb-flag GB CC Facilities Management Limited Status: Aktiv Eintragung: 07.07.2021 Companies House Nummer: 12923370 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • gb-flag GB HS Properties Dean RD LTD Status: Aktiv Eintragung: 07.12.2022 Companies House Nummer: 09165368 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB BG HMO Management LTD Status: Inaktiv Eintragung: 07.12.2022 Löschung: 20.10.2023 Companies House Nummer: 10037362 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Borough Developments JB LTD Status: Inaktiv Eintragung: 08.04.2021 Löschung: 08.04.2021 Companies House Nummer: 11505040 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%
  • gb-flag GB Court Lane Developments 102 LTD Status: Inaktiv Eintragung: 08.04.2021 Löschung: 03.01.2023 Companies House Nummer: 09686758 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • gb-flag GB Court Lane Developments Limited Status: Inaktiv Eintragung: 08.04.2021 Löschung: 03.01.2023 Companies House Nummer: 09660717 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • gb-flag GB Hhss Property Investments LTD Status: Inaktiv Eintragung: 28.05.2020 Löschung: 23.10.2023 Companies House Nummer: 09060199 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • gb-flag GB Highbridge Propertys LTD Status: Inaktiv Eintragung: 07.10.2019 Löschung: 03.01.2023 Companies House Nummer: 09497877 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB SL Properties Francis RD LTD Status: Inaktiv Eintragung: 07.10.2019 Löschung: 03.01.2023 Companies House Nummer: 08944342 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors