UID-Suche.at

UID-Suche


Alle Informationen zu:

                        
Name

Renaissance Land Limited

Adresse
3 Burlington Gardens
London
W1S 3EP
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
Beginn der Umsatzsteuer Registrierung
31. März 2024
FB Adresse C/O Revantage Global Services Uk Ltd Level 19, The Shard
London
SE1 9SG
Firmenbuch-Nummer 14433976 Companies House Eintrag ansehen
JahresabschlussNO ACCOUNTS FILED

Branche (ÖNACE)41100 - Erschließung von Grundstücken; Bauträger
FB Statusactive
KYC Check
KYC / PEP / AML-Abfrage
Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House
Schwarzman, Stephen Status: Aktiv Eintragung: 01.05.2024 Geburtsdatum: 02.1947 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • Bellamy, Martin Status: Inaktiv Eintragung: 22.12.2023 Löschung: 01.05.2024 Geburtsdatum: 05.1969 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%
  • Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
  • gb-flag GB Kogan Bellamy Lloyd Limited Status: Inaktiv Eintragung: 21.10.2022 Löschung: 22.12.2023 Companies House Nummer: 13282714 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%
  • Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
  • gb-flag GB Mitheridge Kbh Limited Status: Inaktiv Eintragung: 21.10.2022 Löschung: 08.02.2023 Companies House Nummer: Tbc Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%
  • Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
  • Officers (6)

    Quelle: Companies House
    Heyl, Yannick Alexander 32 London Bridge Street, London, England Status: Aktiv Eintragung: 01.05.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: German,British
    Kanakis, Rebecca Louise 32 London Bridge Street, London, England Status: Aktiv Eintragung: 01.05.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Lambkin, Jennifer Elizabeth 32 London Bridge Street, London, England Status: Aktiv Eintragung: 01.05.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    gb-flag GB Mourant Governance Services (uk) Limited 52-54 Gracechurch Street, London, United Kingdom, EC3V 0EH Status: Aktiv Eintragung: 31.05.2024 Rolle: Corporate-Secretary Companies House Nummer: 11552614
    Bellamy, Martin James Cardiff, Wales Status: Inaktiv Eintragung: 21.10.2022 Löschung: 01.05.2024 Geburtsdatum: 05.1969 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Lloyd, Benjamin Daniel Cardiff, Wales Status: Inaktiv Eintragung: 21.10.2022 Löschung: 01.05.2024 Geburtsdatum: 07.1985 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British