UID-Suche.at

UID-Suche


Alle Informationen zu:

                        
Name

Torsion (Tritton Road) Devco LTD

Adresse
2175 Century Way Thorpe Par
Leeds
West Yorkshire
LS15 8ZB
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
Beginn der Umsatzsteuer Registrierung
17. November 2019
FB Name Torsion (Tritton Road) Devco Limited
FB Adresse 8 Sackville Street
London
W1S 3DG
Firmenbuch-Nummer 11930833 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschlusstotal-exemption-full
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)41100 - Erschließung von Grundstücken; Bauträger
FB Statusactive
KYC Check
KYC / PEP / AML-Abfrage
Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

Quelle: Companies House
gb-flag GB Hsre Torsion Jv (Tritton Road) Holdco Limited Status: Aktiv Eintragung: 28.08.2020 Companies House Nummer: 12843527 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Hsre Torsion Holdco Limited Status: Inaktiv Eintragung: 28.08.2020 Löschung: 28.08.2020 Companies House Nummer: 12801613 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Hsre Torsion Jv (Tritton Road) Holdco Limited Status: Inaktiv Eintragung: 28.08.2020 Löschung: 08.06.2023 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Hsre Torsion Jv (Tritton Road) Holdco Limited Status: Inaktiv Eintragung: 08.06.2023 Löschung: 08.06.2023 Companies House Nummer: 12843527 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • Spencer, Daniel Thomas Status: Inaktiv Eintragung: 08.04.2019 Löschung: 28.08.2020 Geburtsdatum: 01.1981 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares 75 to 100 percent as firm
  • Voting rights 50 to 75 percent as firm
  • Right to appoint and remove directors as firm
  • Significant influence or control as firm
  • Officers (6)

    Quelle: Companies House
    Chittick, Benjamin Woodworth London, England Status: Aktiv Eintragung: 08.06.2023 Geburtsdatum: 02.1975 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British,American
    Crestbridge Uk Limited, London Status: Aktiv Eintragung: 02.12.2020 Rolle: Secretary
    gb-flag GB Gen Ii Services (uk) Limited Sackville Street, London, W1S 3DG Status: Aktiv Eintragung: 02.12.2020 Rolle: Corporate-Secretary Companies House Nummer: 09822915
    Mcclure, Scott Edward London, England Status: Aktiv Eintragung: 19.07.2023 Geburtsdatum: 07.1979 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Jersey Nationalität: British
    Dearden, Miles Mark Edward Hilton Thorpe Park, Leeds, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 12.11.2019 Löschung: 08.06.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: English
    Spencer, Daniel Thomas Thorpe Park, Leeds, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 08.04.2019 Löschung: 08.06.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British