UID-Suche.at

UID-Suche


Alle Informationen zu:

                        
Name

Albaco Limited

Adresse
Albaco Ltd
Redwood House
5 Redwood Crescent
East Kilbride
G74 5PA
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
Beginn der Umsatzsteuer Registrierung
30. Juli 2024
Firmenbuch-Nummer SC586124 Companies House Eintrag ansehen
Vorherige Namen
  • Alba Bank Limited
  • Alblank Limited
  • KYC Check
    KYC / PEP / AML-Abfrage
    Diese Daten sind inkorrekt?
    Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

    Schnellzugriff

    Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

    Quelle: Companies House
    Koretskiy, Maksym Status: Aktiv Eintragung: 03.09.2024 Geburtsdatum: 04.1981 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%
  • Gehlaut, Sameer Status: Inaktiv Eintragung: 27.02.2023 Löschung: 03.09.2024 Geburtsdatum: 03.1974 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%
  • Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
  • gb-flag GB Lorena Investments Limited Status: Inaktiv Eintragung: 17.05.2022 Löschung: 27.02.2023 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%
  • Mccoll Obe, James Allan Status: Inaktiv Eintragung: 18.01.2018 Löschung: 11.05.2018 Geburtsdatum: 12.1951 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • Officers (21)

    Quelle: Companies House
    Holden, Neil Jonathan Peel Park, East Kilbride, Scotland Status: Aktiv Eintragung: 24.05.2024 Beschäftigung: Chartered Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Kozliar, Andrei Peel Park, East Kilbride, Scotland Status: Aktiv Eintragung: 24.05.2024 Beschäftigung: Non Executive Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Mccoll Obe, James Allan Peel Park, East Kilbride, South Lanarkshire, Scotland Status: Aktiv Eintragung: 18.01.2018 Geburtsdatum: 12.1951 Beschäftigung: None Supplied Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Monaco Nationalität: British
    Rathore, Afshan Peel Park, East Kilbride, Scotland Status: Aktiv Eintragung: 19.02.2025 Rolle: Secretary
    Weatherston, Anne Peel Park, East Kilbride, South Lanarkshire, Scotland Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2020 Geburtsdatum: 12.1956 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British,Australian
    Ashley, Rod Peel Park, East Kilbride, Scotland Status: Inaktiv Eintragung: 11.05.2018 Löschung: 26.01.2024 Geburtsdatum: 06.1969 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Scotland Nationalität: British
    Brettell, Jeremy Macduff Peel Park, East Kilbride, Scotland Status: Inaktiv Eintragung: 24.05.2024 Löschung: 31.05.2022 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Brown, Catherine Ann Peel Park, East Kilbride, Scotland Status: Inaktiv Eintragung: 01.11.2023 Löschung: 20.03.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Cameron, Alexander Charles Peel Park, East Kilbride, Scotland Status: Inaktiv Eintragung: 01.06.2023 Löschung: 26.01.2024 Geburtsdatum: 06.1966 Beschäftigung: General Counsel Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Gehlaut, Sameer Peel Park, East Kilbride, Scotland Status: Inaktiv Eintragung: 26.01.2024 Löschung: 14.05.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Gray, William Michael Peel Park, East Kilbride, Scotland Status: Inaktiv Eintragung: 24.05.2024 Löschung: 25.03.2025 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Jain, Vipin Peel Park, East Kilbride, Scotland Status: Inaktiv Eintragung: 09.04.2024 Löschung: 03.09.2024 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Indian
    Jones, Graeme Reid Peel Park, East Kilbride, Scotland Status: Inaktiv Eintragung: 01.10.2022 Löschung: 28.04.2023 Beschäftigung: Chairman & Ned Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Kumar, Yogesh Peel Park, East Kilbride, Scotland Status: Inaktiv Eintragung: 09.04.2024 Löschung: 08.07.2024 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Indian
    Mustard, Michael William Peel Park, East Kilbride, Scotland Status: Inaktiv Eintragung: 08.01.2024 Löschung: 24.10.2024 Rolle: Secretary
    Picton, Jeffrey Peel Park, East Kilbride, Scotland Status: Inaktiv Eintragung: 01.05.2023 Löschung: 20.03.2024 Geburtsdatum: 12.1958 Beschäftigung: Chartered Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Prasanna, Kasthurirangan Balaji Peel Park, East Kilbride, Scotland Status: Inaktiv Eintragung: 01.05.2023 Löschung: 26.01.2024 Geburtsdatum: 09.1961 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Sharpe, Robert Peel Park, East Kilbride, Scotland Status: Inaktiv Eintragung: 25.08.2023 Löschung: 20.03.2024 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Thompson, Jonathan Ewen Peel Park, East Kilbride, Scotland Status: Inaktiv Eintragung: 09.02.2024 Löschung: 20.03.2024 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Wade, Dominic Simon Francis, M Peel Park, East Kilbride, Scotland Status: Inaktiv Eintragung: 09.02.2024 Löschung: 20.03.2024 Beschäftigung: Chartered Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Waymark, Matthew Edward James Peel Park, East Kilbride, Scotland Status: Inaktiv Eintragung: 24.10.2024 Löschung: 19.02.2025 Rolle: Secretary

    Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (10)

    gb-flag GB Bowness BAY Investments (Holdings) Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 10383185
    gb-flag GB Knoll Investments Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 03014865
    gb-flag Oxcion Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 06826090
    gb-flag GB SO Scandalous LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 14043270
    gb-flag Satixfy UK Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 09966402
    gb-flag Satixfy UK Limited | Satixfy UK Status: Aktiv Companies House Nummer: 09966402
    gb-flag Talgara Retail LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 07536196
    gb-flag Theonegood LTD Status: Aktiv Companies House Nummer: 12249244
    gb-flag ULU Technologies (UK) Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 10200726
    gb-flag GB Zwanenberg Food Group UK Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 01032611