UID-Suche.at

UID-Suche


Alle Informationen zu:

                        
Name

The Thames Club Limited

Adresse
The Thames Club
Wheatsheaf Park
Wheatsheaf Lane
Staines
Surrey
TW18 2PD
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
FB Adresse 6th Floor St Magnus House
London
EC3R 6HD
Firmenbuch-Nummer 06574957 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschlusssmall
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
FB Statusactive
Vorherige Namen
  • Crossco (1104) Limited
  • KYC Check
    KYC / PEP / AML-Abfrage
    Diese Daten sind inkorrekt?
    Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

    Schnellzugriff

    Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

    Quelle: Companies House
    gb-flag GB Thames Club Holdings Limited Status: Aktiv Eintragung: 17.04.2024 Companies House Nummer: 15539767 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Downing Four Vct Plc Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 24.04.2017 Companies House Nummer: 06789187 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%
  • Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
  • gb-flag GB Downing One Vct Plc Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 24.04.2017 Companies House Nummer: 03150868 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%
  • Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
  • Lewis, Stephen Clifton Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 24.04.2017 Geburtsdatum: 08.1956 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%
  • Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
  • Officers (7)

    Quelle: Companies House
    Connell, Jonathan Edward Henley Road, Marlow, England Status: Aktiv Eintragung: 17.04.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    English, Nicholas Spencer Charles Henley Road, Marlow, England Status: Aktiv Eintragung: 17.04.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Marsh, Robert Charles Henley Road, Marlow, England Status: Aktiv Eintragung: 17.04.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Williams, Peter Mark 3 Lower Thames Street, London, England Status: Aktiv Eintragung: 22.05.2014 Geburtsdatum: 06.1960 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Lewis, Stephen Clifton 3 Lower Thames Street, London, England Status: Inaktiv Eintragung: 11.07.2008 Löschung: 17.04.2024 Geburtsdatum: 08.1956 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Robertson, Martin Gordon 3 Lower Thames Street, London, England Status: Inaktiv Eintragung: 26.02.2013 Löschung: 17.04.2024 Geburtsdatum: 08.1966 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Whitehouse, Grant Leslie 3 Lower Thames Street, London, England Status: Inaktiv Eintragung: 10.07.2008 Löschung: 26.04.2024 Geburtsdatum: 03.1966 Rolle: Secretary Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British