UID-Suche.at

UID-Suche


Alle Informationen zu:

                        
Name

Soil Science Limited

Adresse
10 Goldsmith Way
Eliot Business Park
Nuneaton
CV10 7RJ
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
Beginn der Umsatzsteuer Registrierung
25. Februar 2020
Firmenbuch-Nummer 12425259 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschlusssmall
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 28. Februar 2023
Branche (ÖNACE)42990 - Sonstiger Tiefbau a. n. g.
FB Statusactive
Vorherige Namen
  • Geobind Limited
  • Willowmill Limited
  • KYC Check
    KYC / PEP / AML-Abfrage
    Diese Daten sind inkorrekt?
    Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

    Schnellzugriff

    Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

    Quelle: Companies House
    gb-flag GB Grs Integrated Solutions Limited Status: Aktiv Eintragung: 05.12.2023 Companies House Nummer: 04022852 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • Baker, Edward Kenneth Status: Inaktiv Eintragung: 27.02.2020 Löschung: 08.08.2023 Geburtsdatum: 04.1973 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%
  • Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%
  • Right to appoint and remove directors
  • Bush, Nick Status: Inaktiv Eintragung: 27.01.2020 Löschung: 28.01.2020 Geburtsdatum: 03.1955 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • Hinge, William Roger Status: Inaktiv Eintragung: 08.08.2023 Löschung: 05.12.2023 Geburtsdatum: 03.1963 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%
  • Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
  • Right to appoint and remove directors
  • Hinge, William Roger Status: Inaktiv Eintragung: 28.01.2020 Löschung: 27.02.2020 Geburtsdatum: 03.1963 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • Officers (6)

    Quelle: Companies House
    Fisher, Jonathan Gareth Eliot Business Park, Nuneaton, England Status: Aktiv Eintragung: 05.12.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Gifford, Joseph Charles Eliot Business Park, Nuneaton, England Status: Aktiv Eintragung: 05.12.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Hinge, William Roger 99 Church Street, Rickmansworth, England Status: Aktiv Eintragung: 03.08.2023 Geburtsdatum: 03.1963 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Jackson, Paul Anthony 99 Church Street, Rickmansworth, England Status: Aktiv Eintragung: 01.09.2022 Geburtsdatum: 05.1962 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Duffy, Benjamin Andrew Moor Park, Northwood, England Status: Inaktiv Eintragung: 27.02.2020 Löschung: 31.08.2022 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Moore, James Daniel Eliot Business Park, Nuneaton, England Status: Inaktiv Eintragung: 01.07.2020 Löschung: 12.03.2024 Geburtsdatum: 10.1975 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British