UID-Suche.at

UID-Suche


Alle Informationen zu:

                        
Name

Allison Homes South West Limited

Adresse
Larkfleet House
Falcon Way
Southfields Business Park
Bourne
PE10 0FF
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
Beginn der Umsatzsteuer Registrierung
13. Mai 2016
Ende der Umsatzsteuer Registrierung
22. Juni 2022
Firmenbuch-Nummer 07777711 Companies House Eintrag ansehen
Vorherige Namen
  • Larkfleet Homes South West Limited
  • Larkfleet Homes South West L
  • Larkfleet and Dales PV Limited
  • KYC Check
    KYC / PEP / AML-Abfrage
    Diese Daten sind inkorrekt?
    Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

    Schnellzugriff

    Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

    Quelle: Companies House
    gb-flag GB Allison Homes Sw Limited Status: Aktiv Eintragung: 25.01.2018 Companies House Nummer: 10687878 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Larkfleet Homes Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 25.01.2018 Companies House Nummer: 09610856 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • Significant influence or control
  • Officers (7)

    Quelle: Companies House
    Anderson, John Bruce Hampton, Peterborough, England Status: Aktiv Eintragung: 27.07.2020 Geburtsdatum: 05.1963 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Brown, Deborah Hampton, Peterborough, England Status: Aktiv Eintragung: 01.06.2015 Rolle: Secretary
    Fowler, Steven Paul Hampton, Peterborough, England Status: Aktiv Eintragung: 02.01.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Jones, Darren Robert Hampton, Peterborough, England Status: Aktiv Eintragung: 30.10.2022 Geburtsdatum: 03.1969 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Trinder, Ian Jens Hampton, Peterborough, England Status: Aktiv Eintragung: 11.12.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Bennett, Matthew Edward Devonshire Gate, Tiverton, England Status: Inaktiv Eintragung: 31.10.2022 Löschung: 17.11.2023 Geburtsdatum: 09.1975 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Wallwork, Paul Antony Hewitt Southfields Business Park, Bourne Status: Inaktiv Eintragung: 14.07.2022 Löschung: 11.12.2023 Geburtsdatum: 10.1962 Beschäftigung: Finance Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

    Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (9)

    gb-flag GB Hawthorne Gardens Management Company Limited Status: Aktiv Eintragung: 22.11.2018 Companies House Nummer: 11692156 Art der Kontrolle
  • Significant influence or control
  • gb-flag GB Ivybridge Residents Management Company Limited Status: Aktiv Eintragung: 22.11.2018 Companies House Nummer: 11692932 Art der Kontrolle
  • Significant influence or control
  • gb-flag Lhsw (Churchinford) Limited Status: Aktiv Eintragung: 10.04.2016 Companies House Nummer: 10115024 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Lhsw (Creech ST Michael) Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 07777676 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Lhsw (Ivybridge) Limited Status: Aktiv Eintragung: 19.10.2017 Companies House Nummer: 11020836 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Lhsw Churchinford Management Company Limited Status: Aktiv Eintragung: 27.10.2017 Companies House Nummer: 11035829 Art der Kontrolle
  • Significant influence or control
  • gb-flag GB Quantock View Residents Management Company Limited Status: Aktiv Eintragung: 27.06.2019 Companies House Nummer: 12073215 Art der Kontrolle
  • Significant influence or control
  • gb-flag GB The Saxons Residents Management Company Limited Status: Aktiv Eintragung: 05.10.2020 Companies House Nummer: 12930746 Art der Kontrolle
  • Significant influence or control
  • gb-flag GB Willow Heights Residents Management Company Limited Status: Aktiv Eintragung: 11.02.2019 Companies House Nummer: 11818913 Art der Kontrolle
  • Significant influence or control