UID-Suche.at

UID-Suche


Alle Informationen zu:

                        
Name

Sewells Reservoir Construction LTD

Adresse
Crown Business Centre
Old Ipswich Road
Ardleigh
Colchester
CO7 7QR
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
Beginn der Umsatzsteuer Registrierung
8. Dezember 2022
FB Name Sewells Reservoir Construction Limited
Firmenbuch-Nummer 02349942 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschlussfull
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)08990 Other mining and quarrying n.e.c.
38210 - Behandlung und Beseitigung nicht gefährlicher Abfälle
39000 - Beseitigung von Umweltverschmutzungen und sonstige Entsorgung
43110 - Abbrucharbeiten
FB Statusactive
KYC Check
KYC / PEP / AML-Abfrage
Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House
gb-flag GB Sewells Construction Group Limited Status: Aktiv Eintragung: 17.07.2019 Companies House Nummer: 12113933 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • Rees, Oliver John Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 26.02.2019 Geburtsdatum: 11.1987 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%
  • Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
  • gb-flag GB Src Group Holdings Limited Status: Inaktiv Eintragung: 26.02.2019 Löschung: 17.07.2019 Companies House Nummer: 10850220 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • Yeates, Louise Jane Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 26.02.2019 Geburtsdatum: 07.1962 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%
  • Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
  • Officers (9)

    Quelle: Companies House
    Chaplin, Craig Ardleigh, Colchester, England Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2021 Geburtsdatum: 10.1975 Beschäftigung: Contracts Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Gray, Anna Helen Ardleigh, Colchester, England Status: Aktiv Eintragung: 01.11.2024 Beschäftigung: Finance Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Hallworth, Brett James Ardleigh, Colchester, England Status: Aktiv Eintragung: 01.11.2024 Beschäftigung: Operations Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Hunter, David William Ardleigh, Colchester, England Status: Aktiv Eintragung: 18.01.2007 Geburtsdatum: 05.1958 Beschäftigung: Site Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Rees, Oliver John Great Dunmow, Essex, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.10.2011 Geburtsdatum: 11.1987 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    White, Natalie Ardleigh, Colchester, England Status: Aktiv Eintragung: 01.11.2024 Beschäftigung: Operations Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Yeates, Louise Jane Little Canfield, Great Dunmow, Essex, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 13.05.2014 Rolle: Secretary Nationalität: British
    Wise, Thomas Ardleigh, Colchester, England Status: Inaktiv Eintragung: 01.02.2023 Löschung: 31.12.2024 Geburtsdatum: 03.1978 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Yeates, Louise Jane Ardleigh, Colchester, England Status: Inaktiv Eintragung: 08.03.1994 Löschung: 01.07.2024 Geburtsdatum: 07.1962 Beschäftigung: Dir/sec Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

    Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (5)

    gb-flag Allen Newport LTD Status: Aktiv Eintragung: 03.02.2023 Companies House Nummer: 00287279 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag East Coast Marine Aggregates Limited Status: Aktiv Eintragung: 20.08.2021 Companies House Nummer: 13575947 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%
  • Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
  • gb-flag GB Muckit Haulage Limited Status: Aktiv Eintragung: 31.07.2018 Companies House Nummer: 06330296 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Muckit Recycling Limited Status: Aktiv Eintragung: 31.07.2018 Companies House Nummer: 10158387 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB SRC Group Developments Limited Status: Aktiv Eintragung: 20.02.2025 Companies House Nummer: 16265860 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%
  • Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
  • Right to appoint and remove directors