UID-Suche.at

UID-Suche


Alle Informationen zu:

                        
Name

Money Matters (North East) Limited

Adresse
Capital House 1 - 2 Dalaro Court
Kirkleatham Business Park
Redcar
TS10 5RT
VAT ID (UID-Nummer) keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer 07151363 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschlusssmall
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 29. November 2021
Branche (ÖNACE)74909 - Sonstige freiberufliche, wissenschaftliche und technische Tätigkeiten a. n. g.
FB Statusactive
KYC Check
KYC / PEP / AML-Abfrage
Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (7)

Quelle: Companies House
gb-flag GB Hsq Investment Limited Status: Aktiv Eintragung: 14.11.2024 Companies House Nummer: 12156807 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%
  • Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%
  • gb-flag GB Kingswood Holdings Limited Status: Inaktiv Eintragung: 30.11.2021 Löschung: 27.10.2022 Companies House Nummer: 00042316 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Kw Uk Bidco Limited Status: Inaktiv Eintragung: 27.10.2022 Löschung: 20.12.2022 Companies House Nummer: 00070885 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Kw Uk Financial Holdings Limited Status: Inaktiv Eintragung: 27.10.2022 Löschung: 27.10.2022 Companies House Nummer: 00070880 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Kw Uk Wealth Planning Holdco Limited Status: Inaktiv Eintragung: 20.12.2022 Löschung: 14.11.2024 Companies House Nummer: 00071106 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • Raine, Alastair Simon Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 30.11.2021 Geburtsdatum: 03.1966 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%
  • Raine, Deborah Louise Status: Inaktiv Eintragung: 07.11.2019 Löschung: 30.11.2021 Geburtsdatum: 06.1973 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%
  • Officers (4)

    Quelle: Companies House
    Coleman, Peter Brian Kirkleatham Business Park, Redcar, England Status: Aktiv Eintragung: 14.08.2024 Beschäftigung: Chief Executive Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Hammick, Paul Alan Kirkleatham Business Park, Redcar, England Status: Aktiv Eintragung: 16.05.2023 Geburtsdatum: 11.1973 Beschäftigung: Chief Risk Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Lawrence, David Frank London, England Status: Inaktiv Eintragung: 30.11.2021 Löschung: 14.08.2024 Geburtsdatum: 09.1968 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Nursiah, Vinoy Rajanah Kirkleatham Business Park, Redcar, England Status: Inaktiv Eintragung: 04.12.2024 Löschung: 20.01.2025 Beschäftigung: Cfo Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British