UID-Suche.at

UID-Suche


Alle Informationen zu:

                        
Name

Cripps Trust Corporation Limited

Adresse
Number 22
Mount Ephraim
Tunbridge Wells
TN4 8AS
VAT ID (UID-Nummer) keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer 03491458 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschlussdormant
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. April 2022
Branche (ÖNACE)82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
FB Statusactive
KYC Check
KYC / PEP / AML-Abfrage
Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House
gb-flag GB Cripps Llp Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: Oc311169 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • Officers (13)

    Quelle: Companies House
    Arnold, Laura Kate Tunbridge Wells, Kent Status: Aktiv Eintragung: 22.09.2014 Geburtsdatum: 07.1981 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Beatton, James Robert Tunbridge Wells, Kent Status: Aktiv Eintragung: 30.09.2018 Geburtsdatum: 11.1969 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Cripps Secretaries Limited, Tunbridge Wells, Kent, England Status: Aktiv Eintragung: 13.01.1998 Rolle: Secretary Nationalität: British
    Curtis, Jeremy David Godfrey Tunbridge Wells, Kent Status: Aktiv Eintragung: 13.12.2018 Geburtsdatum: 12.1966 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Fairbairn, Paul Frederick Charles Tunbridge Wells, Kent Status: Aktiv Eintragung: 22.06.2018 Geburtsdatum: 06.1982 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Fairley, Victoria Jane Tunbridge Wells, Kent Status: Aktiv Eintragung: 30.11.2021 Geburtsdatum: 07.1973 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Horscroft, Stephen David Tunbridge Wells, Kent Status: Aktiv Eintragung: 23.11.2020 Geburtsdatum: 04.1986 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Jamieson, Jessica Isabelle Lucy Tunbridge Wells, Kent Status: Aktiv Eintragung: 28.06.2017 Geburtsdatum: 03.1979 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Mcintosh, Myles Stephen Tunbridge Wells, Kent Status: Aktiv Eintragung: 20.02.2018 Geburtsdatum: 05.1969 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Scott, Peter John Miller 12 Mount Ephraim Road, Tunbridge Wells, Kent Status: Aktiv Eintragung: 18.12.1998 Geburtsdatum: 09.1950 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Simpson, Bruce Russell Tunbridge Wells, Kent Status: Aktiv Eintragung: 20.02.2018 Geburtsdatum: 05.1961 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Youdan, Philip Tunbridge Wells, Kent Status: Aktiv Eintragung: 20.02.2018 Geburtsdatum: 05.1976 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Mcintosh, Fiona Elizabeth Tunbridge Wells Status: Inaktiv Eintragung: 30.04.2010 Löschung: 19.04.2024 Geburtsdatum: 11.1969 Beschäftigung: Solicitors Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

    Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (7)

    gb-flag GB Caxton Homes Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 05136605 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • gb-flag EH Nicholls Holdings Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 03908191 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares 75 to 100 percent as trust
  • Voting rights 75 to 100 percent as trust
  • Significant influence or control as trust
  • gb-flag GB Greenmantle Property LTD Status: Aktiv Eintragung: 21.07.2016 Companies House Nummer: 09317583 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • gb-flag Salmon Management and Finance LTD Status: Aktiv Eintragung: 23.08.2018 Companies House Nummer: 00473430 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB The Stanmer Park Partnership LTD Status: Aktiv Eintragung: 30.05.2018 Companies House Nummer: 11388762 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Hambleton (Kent) LTD Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 05.04.2023 Companies House Nummer: 10057819 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%
  • Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
  • gb-flag GB LDK Investments LTD Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 01.01.2019 Companies House Nummer: 09943907 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%
  • Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%