UID-Suche.at

UID-Suche


Alle Informationen zu:

                        
Name

CCH Financial Strategies Limited

Adresse
C/O Cox Costello & Horne Batchworth Lock House
99 Church Street
Rickmansworth
WD3 1JJ
VAT ID (UID-Nummer) keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer 04751985 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschlusstotal-exemption-full
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Oktober 2022
Branche (ÖNACE)64999 - Sonstige Finanzdienstleistungen a. n. g.
FB Statusactive
KYC Check
KYC / PEP / AML-Abfrage
Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House
Cox, Michael Status: Aktiv Eintragung: 03.05.2020 Geburtsdatum: 05.1958 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Cox Costello & Horne Limited Status: Inaktiv Eintragung: 01.07.2016 Löschung: 03.05.2020 Companies House Nummer: 04460685 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Felton & Farnworth Limited Status: Inaktiv Eintragung: 03.05.2020 Löschung: 03.05.2020 Companies House Nummer: 06456498 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • Officers (5)

    Quelle: Companies House
    Cox, Fiona Jane Mason 99 Church Street, Rickmansworth, England Status: Aktiv Eintragung: 27.04.2022 Geburtsdatum: 01.1964 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Cox, Katherine Anne 99 Church Street, Rickmansworth, England Status: Aktiv Eintragung: 29.04.2022 Geburtsdatum: 09.1986 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Cox, Michael Francis 99 Church Street, Rickmansworth, England Status: Aktiv Eintragung: 18.05.2015 Geburtsdatum: 05.1958 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    gb-flag GB Kerry Secretarial Services Limited Batchworth Lock House, 99 Church Street, Rickmansworth, England, WD3 1JJ Status: Aktiv Eintragung: 02.05.2003 Rolle: Corporate-Secretary Companies House Nummer: 03427021
    Kerry Secretarial Services Limited, Moor Park, Northwood, England Status: Aktiv Eintragung: 02.05.2003 Beschäftigung: Company Secretary Rolle: Secretary

    Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (6)

    gb-flag AML Compliance Limited Status: Aktiv Eintragung: 31.03.2022 Companies House Nummer: 08864276 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB CCH Cardpay Limited Status: Aktiv Eintragung: 01.04.2022 Companies House Nummer: 10053862 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB CCH Limited Status: Aktiv Eintragung: 31.03.2021 Companies House Nummer: 03611878 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • gb-flag GB CCH Nominees Limited Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2016 Companies House Nummer: 04117831 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Bounce Back Exercise Limited Status: Inaktiv Eintragung: 31.03.2021 Löschung: 31.03.2021 Companies House Nummer: 12647114 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Philpott & Company Services Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 05.01.2018 Companies House Nummer: 04477955 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more