UID-Suche.at

UID-Suche


Alle Informationen zu:

                        
Name

Allison Homes SW Limited

Adresse
Larkfleet House
Falcon Way Southfields Busi
Bourne
Lincolnshire
PE10 0FF
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
Beginn der Umsatzsteuer Registrierung
30. April 2018
FB Adresse Fleet House Cygnet Road
Bourne
PE7 8FD
Firmenbuch-Nummer 10687878 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschlussfull
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2021
Branche (ÖNACE)41202 - Bau von Gebäuden
FB Statusactive
Vorherige Namen
  • Larkfleet SW Limited
  • Larkfleet East Anglia Limited
  • KYC Check
    KYC / PEP / AML-Abfrage
    Diese Daten sind inkorrekt?
    Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

    Schnellzugriff

    Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

    Quelle: Companies House
    gb-flag GB Allison Homes Group Limited Status: Aktiv Eintragung: 23.03.2017 Companies House Nummer: 10653289 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • Officers (7)

    Quelle: Companies House
    Anderson, John Bruce Hampton, Peterborough, England Status: Aktiv Eintragung: 27.07.2020 Geburtsdatum: 05.1963 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Brown, Deborah Jane Hampton, Peterborough, England Status: Aktiv Eintragung: 23.03.2017 Rolle: Secretary
    Fowler, Steven Paul Hampton, Peterborough, England Status: Aktiv Eintragung: 02.01.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Jones, Darren Robert Hampton, Peterborough, England Status: Aktiv Eintragung: 30.10.2022 Geburtsdatum: 03.1969 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Trinder, Ian Jens Hampton, Peterborough, England Status: Aktiv Eintragung: 11.12.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Bennett, Matthew Edward Devonshire Gate, Tiverton, England Status: Inaktiv Eintragung: 31.10.2022 Löschung: 17.11.2023 Geburtsdatum: 09.1975 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Wallwork, Paul Antony Hewitt Southfields Business Park, Bourne, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 14.07.2022 Löschung: 11.12.2023 Geburtsdatum: 10.1962 Beschäftigung: Finance Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

    Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (7)

    gb-flag Allison Homes South West Limited Status: Aktiv Eintragung: 25.01.2018 Companies House Nummer: 07777711 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Buttercross Meadow Somerton Management Company Limited Status: Aktiv Eintragung: 27.03.2024 Companies House Nummer: 14093098 Art der Kontrolle
  • Significant influence or control
  • gb-flag GB Foxglove View Buckland Brewer Management Company Limited Status: Aktiv Eintragung: 27.03.2024 Companies House Nummer: 14278181 Art der Kontrolle
  • Significant influence or control
  • gb-flag GB High Moor View Winkleigh Management Company Limited Status: Aktiv Eintragung: 27.03.2024 Companies House Nummer: 14091871 Art der Kontrolle
  • Significant influence or control
  • gb-flag GB Primrose Meadows Management Company Limited Status: Aktiv Eintragung: 27.03.2024 Companies House Nummer: 14741633 Art der Kontrolle
  • Significant influence or control
  • gb-flag GB The Orchard AT Langport Management Company Limited Status: Aktiv Eintragung: 24.09.2021 Companies House Nummer: 13640989 Art der Kontrolle
  • Significant influence or control as firm
  • gb-flag GB Weavers Place North Tawton Management Company Limited Status: Aktiv Eintragung: 27.03.2024 Companies House Nummer: 14278218 Art der Kontrolle
  • Significant influence or control