UID-Suche.at

UID-Suche


Alle Informationen zu:

                        
Name

CHP Investments 3 Limited

Adresse
Forum 4 Solent Business Park
Parkway South, Whiteley
Fareham
PO15 7AD
VAT ID (UID-Nummer) keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer 14509674 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschlusssmall

Branche (ÖNACE)68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
FB Statusactive
KYC Check
KYC / PEP / AML-Abfrage
Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House
gb-flag GB Wellness Legion Uk Limited Status: Aktiv Eintragung: 28.11.2022 Companies House Nummer: 11518817 Art der Kontrolle
  • Significant influence or control
  • Officers (5)

    Quelle: Companies House
    Bellew, Edward Alexander Parkway South, Whiteley, Fareham, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 28.11.2022 Geburtsdatum: 05.1977 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Dawber, Andrew Joseph Parkway South, Whiteley, Fareham, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 28.11.2022 Geburtsdatum: 12.1961 Beschäftigung: Group Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Fahey, Claire Louise Parkway South, Whiteley, Fareham, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 28.11.2022 Geburtsdatum: 11.1979 Beschäftigung: Finance Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Pridmore, Thomas Clifford Parkway South, Whiteley, Fareham, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 28.11.2022 Geburtsdatum: 03.1972 Beschäftigung: Group Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Young, Matthew Parkway South, Whiteley, Fareham, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 02.08.2023 Beschäftigung: Senior Financial Reporting Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

    Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (8)

    gb-flag GB Bramfield House School Limited Status: Aktiv Eintragung: 15.08.2024 Companies House Nummer: 05527671 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Crookhey Hall Limited Status: Aktiv Eintragung: 15.08.2024 Companies House Nummer: 02729238 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Heath Farm Limited Status: Aktiv Eintragung: 15.08.2024 Companies House Nummer: 02582284 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Kestrel House School Limited Status: Aktiv Eintragung: 15.08.2024 Companies House Nummer: 07442995 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Longdon Hall School Limited Status: Aktiv Eintragung: 15.08.2024 Companies House Nummer: 07443059 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Options Autism (1) Limited Status: Aktiv Eintragung: 15.08.2024 Companies House Nummer: 04064685 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Options Autism (5) Limited Status: Aktiv Eintragung: 15.08.2024 Companies House Nummer: 05697730 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Waterloo Lodge School LTD. Status: Aktiv Eintragung: 15.08.2024 Companies House Nummer: 03921801 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors