UID-Suche.at

UID-Suche


Alle Informationen zu:

                        
Name

Vinshire GAS Services Limited

Adresse
Unit 5A-5B, Sinfin Commerci
Sinfin Lane
Derby
DE24 9HL
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
Beginn der Umsatzsteuer Registrierung
24. Mai 2020
Ende der Umsatzsteuer Registrierung
31. Mai 2024
FB Adresse Norfolk House
Dartford
WC1A 2AJ
Firmenbuch-Nummer 12557988 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschlussaudit-exemption-subsidiary
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2022
Branche (ÖNACE)96090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen a. n. g.
FB Statusactive
Vorherige Namen
  • East Midlands Plumbing and Heating Services Limited
  • KYC Check
    KYC / PEP / AML-Abfrage
    Diese Daten sind inkorrekt?
    Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

    Schnellzugriff

    Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

    Quelle: Companies House
    gb-flag GB Sureserve Vgs Limited Status: Aktiv Eintragung: 03.12.2020 Companies House Nummer: 09829080 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • Burdell, Nicholas Status: Inaktiv Eintragung: 15.04.2020 Löschung: 03.12.2020 Geburtsdatum: 06.1967 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%
  • Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
  • Right to appoint and remove directors
  • Clark, Nicholas Paul Status: Inaktiv Eintragung: 15.04.2020 Löschung: 03.12.2020 Geburtsdatum: 07.1969 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%
  • Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Vinshire Plumbing And Heating Limited Status: Inaktiv Eintragung: 03.12.2020 Löschung: 03.12.2020 Companies House Nummer: 02389216 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • Officers (6)

    Quelle: Companies House
    Lummis, David Matthew London, England Status: Aktiv Eintragung: 03.12.2020 Geburtsdatum: 03.1979 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Mayhill, Geoffrey Ronald London, England Status: Aktiv Eintragung: 01.05.2024 Rolle: Secretary
    Vohra, Sameet Crossways Business Park, Dartford, Kent, England Status: Aktiv Eintragung: 13.04.2022 Geburtsdatum: 11.1973 Beschäftigung: Chief Financial Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Charlton, John William Charles London, England Status: Inaktiv Eintragung: 03.12.2020 Löschung: 01.05.2024 Rolle: Secretary
    Smith, Peter David Mawby Crossways Business Park, Dartford, England Status: Inaktiv Eintragung: 03.12.2020 Löschung: 26.09.2023 Geburtsdatum: 02.1971 Beschäftigung: Chief Financial Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Vohra, Sam Crossways Business Park, Dartford, England Status: Inaktiv Eintragung: 08.08.2023 Löschung: 31.08.2023 Beschäftigung: Finance Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British