UID-Suche.at

UID-Suche


Alle Informationen zu:

                        
Name

Petrogas Group UK LTD

Adresse
Office 3, The Limes
Dunstable Street
Ampthill
MK45 2GJ
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
Beginn der Umsatzsteuer Registrierung
16. November 2017
FB Name Petrogas Group UK Limited
FB Adresse Waterside Head Office Haslingden Road
Bedford
BB1 2FA
Firmenbuch-Nummer 05952225 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschlussfull
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)47300 - Einzelhandel mit Motorenkraftstoffen (Tankstellen)
FB Statusactive
KYC Check
KYC / PEP / AML-Abfrage
Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House
gb-flag GB Eg Retail Services Limited Status: Aktiv Eintragung: 31.01.2025 Companies House Nummer: 13920167 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Applegreen Plc Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 31.01.2025 Companies House Nummer: 00491702 Art der Kontrolle
  • Significant influence or control
  • gb-flag GB Petrogas Holdings Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 30.10.2018 Companies House Nummer: 00528470 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Petrogas Holdings Uk Limited Status: Inaktiv Eintragung: 30.10.2018 Löschung: 31.01.2025 Companies House Nummer: 11547977 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • Officers (7)

    Quelle: Companies House
    Issa, Zuber Vali Guide, Blackburn, England Status: Aktiv Eintragung: 31.01.2025 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Barrett, Joseph James Donnybrook, Dublin, Ireland Status: Inaktiv Eintragung: 07.11.2006 Löschung: 31.01.2025 Geburtsdatum: 07.1966 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Ireland Nationalität: Irish
    Barrett, Joseph James Donnybrook, Dublin, Ireland Status: Inaktiv Eintragung: 12.06.2008 Löschung: 31.01.2025 Beschäftigung: Director Rolle: Secretary Nationalität: Irish
    Brett-Lee, Martyn Dunstable Street, Ampthill, England Status: Inaktiv Eintragung: 03.04.2023 Löschung: 31.01.2025 Geburtsdatum: 03.1985 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Dolan, Niall Guide, Blackburn, England Status: Inaktiv Eintragung: 04.09.2017 Löschung: 31.01.2025 Geburtsdatum: 08.1973 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Ireland Nationalität: Irish
    Grimes, Adrian Newport Pagnell, England Status: Inaktiv Eintragung: 02.06.2021 Löschung: 31.01.2025 Geburtsdatum: 06.1971 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Irish
    Kyte, Darren Stephen The Limes, Newport Pagnell, England Status: Inaktiv Eintragung: 03.04.2023 Löschung: 31.01.2025 Geburtsdatum: 03.1966 Beschäftigung: Group Treasurer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

    Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (8)

    gb-flag GB BMC Petroleum Limited Status: Aktiv Eintragung: 02.10.2017 Companies House Nummer: 05396497 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Casterton Hill Service Station Limited Status: Aktiv Eintragung: 02.10.2017 Companies House Nummer: 08227879 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Cromwell Service Station Limited Status: Aktiv Eintragung: 02.10.2017 Companies House Nummer: 05509537 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag MCM Forecourts LTD | Wisebech Road Services Station Status: Aktiv Eintragung: 02.10.2017 Companies House Nummer: 08195075 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB MCM Sandwiches Limited Status: Aktiv Eintragung: 02.10.2017 Companies House Nummer: 08696333 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Muskham Services Limited Status: Aktiv Eintragung: 02.10.2017 Companies House Nummer: 06631867 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Petrogas Group (Western) Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 06867725 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Wyboston Service Station Limited Status: Aktiv Eintragung: 02.10.2017 Companies House Nummer: 07724931 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors