UID-Suche.at

UID-Suche


Alle Informationen zu:

                        
Name

VX Fiber Limited

Adresse
Ground Floor
45 Pall Mall
London
SW1Y 5JG
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
Beginn der Umsatzsteuer Registrierung
21. Mai 2017
FB Adresse Floor, Ic2 Floor, Ic2
Guildford
ST5 5NH
Firmenbuch-Nummer 10556810 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschlussfull
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2022
Branche (ÖNACE)62030 - Betrieb von Datenverarbeitungseinrichtungen für Dritte
62090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen der Informationstechnologie
FB Statusactive
Vorherige Namen
  • Vnxt UK Limited
  • KYC Check
    KYC / PEP / AML-Abfrage
    Diese Daten sind inkorrekt?
    Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

    Schnellzugriff

    Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

    Quelle: Companies House
    gb-flag GB Freedom Fibre Limited Status: Aktiv Eintragung: 26.03.2024 Companies House Nummer: 13006400 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Digitalbridge Group, Inc Status: Inaktiv Eintragung: 02.02.2023 Löschung: 08.03.2024 Companies House Nummer: D17285487 Art der Kontrolle
  • Significant influence or control
  • gb-flag GB Infrabridge Investors (Uk) Limited Status: Inaktiv Eintragung: 02.02.2023 Löschung: 08.03.2024 Companies House Nummer: 05524536 Art der Kontrolle
  • Significant influence or control
  • gb-flag GB Vnext Ab Status: Inaktiv Eintragung: 10.01.2017 Löschung: 02.02.2023 Companies House Nummer: 5569859506 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • gb-flag GB Vx Uk Holdings Limited Status: Inaktiv Eintragung: 08.03.2024 Löschung: 26.03.2024 Companies House Nummer: 15240946 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • Officers (6)

    Quelle: Companies House
    Mcarthur, Neil Science Park, University Of Keele, Newcastle-Under-Lyme, England Status: Aktiv Eintragung: 26.03.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Moore, Anthony Science Park, University Of Keele, Newcastle-Under-Lyme, England Status: Aktiv Eintragung: 26.03.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Woods, Darren John Science Park, University Of Keele, Newcastle-Under-Lyme, England Status: Aktiv Eintragung: 26.03.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Block, Carl Stefan Demetrios Guildford, England Status: Inaktiv Eintragung: 16.03.2023 Löschung: 26.03.2024 Geburtsdatum: 09.1967 Beschäftigung: Chief Financial Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Sweden Nationalität: Swedish
    Lange, Jan Helge Guildford, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 16.03.2023 Löschung: 26.03.2024 Geburtsdatum: 08.1971 Beschäftigung: Chief Commercial Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Germany Nationalität: German
    SÖrensen, Jens Fredrik Guildford, England Status: Inaktiv Eintragung: 16.03.2023 Löschung: 26.03.2024 Geburtsdatum: 04.1971 Beschäftigung: Chief Deployment Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Sweden Nationalität: Swedish