UID-Suche.at

UID-Suche


Alle Informationen zu:

                        
Name

Galliard Homes Limited

Adresse
3rd Floor
Sterling House
Langston Road
Loughton
Essex
IG10 3TS
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
Firmenbuch-Nummer 02158998 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschlussfull
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)41100 - Erschließung von Grundstücken; Bauträger
FB Statusactive
KYC Check
KYC / PEP / AML-Abfrage
Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House
gb-flag GB Galliard Holdings Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 03368629 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • Officers (13)

    Quelle: Companies House
    Conway, David Edward Sterling House Langston Road, Loughton, Essex Status: Aktiv Eintragung: 24.01.2011 Geburtsdatum: 07.1976 Beschäftigung: Property Developer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Conway, Gary Alexander Sterling House Langston Road, Loughton, Essex Status: Aktiv Eintragung: 13.12.2021 Geburtsdatum: 09.1973 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Conway, Richard Mathew Sterling House Langston Road, Loughton Status: Aktiv Eintragung: 13.12.2021 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Conway, Richard Matthew Sterling House Langston Road, Loughton, Essex Status: Aktiv Eintragung: 13.12.2021 Geburtsdatum: 10.1978 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Conway, Stephen Stuart Solomon Sterling House Langston Road, Loughton Status: Aktiv Eintragung: 01.05.1993 Geburtsdatum: 02.1948 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Dias, Eli Sterling House Langston Road, Loughton, Essex Status: Aktiv Eintragung: 31.05.2022 Geburtsdatum: 09.1991 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Dijk, Amanda Louise Sterling House Langston Road, Loughton, Essex Status: Aktiv Eintragung: 15.08.2017 Geburtsdatum: 09.1976 Beschäftigung: Group Financial Controller Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Hirschfield, David Joseph Sterling House Langston Road, Loughton, Essex Status: Aktiv Eintragung: 14.01.2016 Geburtsdatum: 05.1985 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Hirschfield, David Joseph Sterling House Langston Road, Loughton, Essex Status: Aktiv Eintragung: 31.12.2022 Rolle: Secretary
    Huberman, Paul Laurence Sterling House Langston Road, Loughton, Essex Status: Aktiv Eintragung: 17.02.2015 Geburtsdatum: 06.1961 Beschäftigung: Chartered Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Maguire, Darren Paul Sterling House Langston Road, Loughton, Essex Status: Aktiv Eintragung: 01.04.2022 Geburtsdatum: 08.1970 Beschäftigung: Construction Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Irish
    Watson, Michael John Sterling House Langston Road, Loughton, Essex Status: Aktiv Eintragung: 29.08.2014 Geburtsdatum: 05.1974 Beschäftigung: Architectural & Technical Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Ranjan, Kailayapillai Sterling House Langston Road, Loughton Status: Inaktiv Eintragung: 30.11.2007 Löschung: 02.04.2012 Beschäftigung: Finance Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

    Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (6)

    gb-flag GB GHL (Ufford ST) Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 06657930 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Handspot Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 05384189 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Netcircle Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 04872173 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag Packamist LTD Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 02850256 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%
  • Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
  • gb-flag GB Shore Waters Management Company Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 04728522 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag Workout LTD Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 04905501 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors