UID-Suche.at

UID-Suche


Alle Informationen zu:

                        
Name

Cloud Trade Technologies Limited

Adresse
1-2
Hatfields
London
Greater London
SE1 9PG
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
Beginn der Umsatzsteuer Registrierung
22. März 2018
Ende der Umsatzsteuer Registrierung
21. Juni 2024
FB Adresse The Mailbox Level 3
Birmingham
B1 1RF
Firmenbuch-Nummer 07039186 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschlussaudit-exemption-subsidiary
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 28. Februar 2022
Branche (ÖNACE)62012 - Programmierungstätigkeiten
FB Statusactive
Vorherige Namen
  • Cloud Trade Technologies Limited | Cloudtrade
  • Cloud Trade Technologies Limited Cloudtrade
  • Procsure Limited
  • KYC Check
    KYC / PEP / AML-Abfrage
    Diese Daten sind inkorrekt?
    Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

    Schnellzugriff

    Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

    Quelle: Companies House
    gb-flag GB Advanced Business Software And Solutions Limited Status: Aktiv Eintragung: 14.10.2021 Companies House Nummer: 03214465 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • Cocks, David Alan Status: Inaktiv Eintragung: 26.07.2018 Löschung: 14.10.2021 Geburtsdatum: 08.1954 Art der Kontrolle
  • Significant influence or control
  • Cocks, David Alan Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 26.07.2018 Geburtsdatum: 08.1954 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%
  • Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
  • Develyn, Richard Alexander Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 26.07.2018 Geburtsdatum: 08.1963 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%
  • Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
  • Manson, Richard Allan John Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 26.07.2018 Geburtsdatum: 02.1971 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%
  • Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
  • Officers (4)

    Quelle: Companies House
    Aspell, Jayne Louise Birmingham, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 26.04.2022 Rolle: Secretary
    Dews, Stephen Eric 101 Wharfside Street, Birmingham, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 09.06.2023 Geburtsdatum: 10.1975 Beschäftigung: Finance Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Walsh, Simon David 101 Wharfside Street, Birmingham, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 09.06.2023 Geburtsdatum: 07.1971 Beschäftigung: Ceo Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Kerr, Richard James Birmingham, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 01.02.2022 Löschung: 10.02.2023 Beschäftigung: Chief Finance Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

    Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

    gb-flag GB Keyword Logic LTD Status: Aktiv Eintragung: 24.09.2021 Companies House Nummer: 04967920 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more