UID-Suche.at

UID-Suche


Alle Informationen zu:

                        
Name

Schlumberger Oilfield UK Limited

Adresse
Enterprise Drive
Westhill Industrial Estate
Westhill
AB32 6TQ
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
Beginn der Umsatzsteuer Registrierung
19. November 2020
Firmenbuch-Nummer 04157867 Companies House Eintrag ansehen
Vorherige Namen
  • Schlumberger Oilfield UK PLC
  • KYC Check
    KYC / PEP / AML-Abfrage
    Diese Daten sind inkorrekt?
    Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

    Schnellzugriff

    Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

    Quelle: Companies House
    gb-flag GB Schlumberger Public Limited Company Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 01332348 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • Officers (12)

    Quelle: Companies House
    Adhia, Rakesh London, England And Wales, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.05.2021 Geburtsdatum: 09.1974 Beschäftigung: Controller Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Beddall, Colin David Lauderdale Road, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 31.07.2022 Geburtsdatum: 07.1970 Beschäftigung: Risk & Insurance Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Fox, Robert Edward Anselm Westhill, Aberdeen, Aberdeenshire, Scotland, Scotland Status: Aktiv Eintragung: 04.02.2022 Geburtsdatum: 05.1972 Beschäftigung: General Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Haddon, Aaron Dwight Westhill, Aberdeen, Aberdeenshire, Scotland Status: Aktiv Eintragung: 28.06.2024 Beschäftigung: Sales & Marketing Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Scotland Nationalität: British
    Labbe, Christelle Sandrine London, England And Wales, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 30.09.2020 Geburtsdatum: 07.1975 Beschäftigung: Wg Eaf Personnel Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: French
    Nekakhtar, Sama Westhill, Aberdeen, Aberdeenshire, Scotland Status: Aktiv Eintragung: 16.08.2024 Beschäftigung: Finance Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Scotland Nationalität: Pakistani
    O’connor, Eilish Jane Stroudwater Business Park, Stonehouse, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 21.09.2024 Beschäftigung: Technology Centre Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Irish
    Rait, Kenneth Robert Westhill, Aberdeen, Aberdeenshire, Scotland, Scotland Status: Aktiv Eintragung: 07.04.2023 Geburtsdatum: 02.1973 Beschäftigung: Eur Hse Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Scotland Nationalität: British
    Ballard, Gordon George Reid Beechwood Avenue, Weybridge Status: Inaktiv Eintragung: 26.07.2005 Löschung: 30.06.2015 Beschäftigung: Engineer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Beddall, Colin David, Mr. Lauderdale Road, London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 31.07.2022 Löschung: 15.08.2024 Beschäftigung: Risk & Insurance Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Nugent, Gregory John Stroudwater Business Park, Stonehouse, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 01.11.2021 Löschung: 22.07.2024 Geburtsdatum: 08.1977 Beschäftigung: Technology Center Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Canadian
    Walker, Christopher Allan Westhill, Aberdeen, Aberdeenshire, Scotland Status: Inaktiv Eintragung: 18.08.2022 Löschung: 29.06.2024 Geburtsdatum: 07.1984 Beschäftigung: Finance Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Scotland Nationalität: American

    Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (7)

    gb-flag GB Cameron Petroleum (UK) Limited Status: Aktiv Eintragung: 01.01.2017 Companies House Nummer: 04589882 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Onesubsea Investments UK Limited Status: Aktiv Eintragung: 21.02.2017 Companies House Nummer: 08431671 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%
  • Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag QLM Technology Limited Status: Aktiv Eintragung: 03.08.2022 Companies House Nummer: 10673098 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%
  • Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
  • gb-flag QLM Technology Limited Status: Aktiv Eintragung: 03.08.2022 Companies House Nummer: 10673098 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%
  • Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
  • gb-flag GB Sensor Highway Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 03148432 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag Diamould LTD Status: Inaktiv Eintragung: 29.03.2017 Löschung: 01.06.2023 Companies House Nummer: 03797278 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Independent Data Services (UK) Unlimited Status: Inaktiv Eintragung: 03.09.2021 Löschung: 29.12.2021 Companies House Nummer: 04855776 Art der Kontrolle
  • Significant influence or control