UID-Suche.at

UID-Suche


Alle Informationen zu:

                        
Name

Jason Patrick Holdings Limited

Adresse
95A High Street
Wimbledon Village
London
SW19 5EG
VAT ID (UID-Nummer) keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer 11617081 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschlussmicro-entity
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
68320 - Verwaltung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte
70229 - Unternehmensberatung
FB Statusactive
KYC Check
KYC / PEP / AML-Abfrage
Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House
Collins, Jason Patrick Status: Aktiv Eintragung: 11.10.2018 Geburtsdatum: 01.1970 Art der Kontrolle
  • Significant influence or control
  • Collins, Demi Jessica Status: Inaktiv Eintragung: 11.10.2018 Löschung: 04.08.2021 Geburtsdatum: 05.1998 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%
  • Right to appoint and remove directors
  • Collins, Jay Ellis Status: Inaktiv Eintragung: 11.10.2018 Löschung: 04.08.2021 Geburtsdatum: 04.1993 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%
  • Right to appoint and remove directors
  • Collins, Sarah Samantha Status: Inaktiv Eintragung: 11.10.2018 Löschung: 04.08.2021 Geburtsdatum: 11.1969 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%
  • Right to appoint and remove directors
  • Officers (4)

    Quelle: Companies House
    Collins, Demi Jessica Wimbledon Village, London, England Status: Aktiv Eintragung: 13.12.2021 Geburtsdatum: 05.1998 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Collins, Jason Patrick Wimbledon Village, London, England Status: Aktiv Eintragung: 11.10.2018 Geburtsdatum: 01.1970 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Collins, Jay Ellis Wimbledon Village, London, England Status: Aktiv Eintragung: 13.12.2021 Geburtsdatum: 04.1993 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Collins, Jay Ellis Wimbledon Village, London, England Status: Aktiv Eintragung: 06.12.2019 Rolle: Secretary

    Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (10)

    gb-flag GB 32 Cliveden Place Belgravia Limited Status: Aktiv Eintragung: 04.08.2021 Companies House Nummer: 12604101 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Brendon Street Limited Status: Aktiv Eintragung: 04.08.2021 Companies House Nummer: 12578808 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Bromley Hill Limited Status: Aktiv Eintragung: 04.08.2021 Companies House Nummer: 12454103 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB JPH Investment 2022 Limited Status: Aktiv Eintragung: 27.04.2022 Companies House Nummer: 14073111 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB ONE Oakley Street SW3 Limited Status: Aktiv Eintragung: 27.04.2023 Companies House Nummer: 14831057 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB ONE Oakley Street SW3 Limited Status: Aktiv Eintragung: 27.04.2023 Companies House Nummer: 14831057 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Sloane Gable Estates Limited Status: Aktiv Eintragung: 04.08.2021 Companies House Nummer: 12432168 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag Sloane Gable Limited Status: Aktiv Eintragung: 26.09.2021 Companies House Nummer: 09295436 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB 95 High Street Wimbledon Limited Status: Inaktiv Eintragung: 04.08.2021 Löschung: 04.01.2022 Companies House Nummer: 13496777 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB VEL Assets Management Limited Status: Inaktiv Eintragung: 04.08.2021 Löschung: 01.03.2024 Companies House Nummer: 11619070 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors