UID-Suche.at

UID-Suche


Alle Informationen zu:

                        
Name

Jaeger Retail Limited

Adresse
C/O Frp Advisory Trading Limit
2nd Floor
110 Cannon Street
London
EC4N 6EU
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
Beginn der Umsatzsteuer Registrierung
27. Mai 2017
Ende der Umsatzsteuer Registrierung
6. Juli 2021
FB Adresse Jupiter House Warley Business Park
Brentwood
CM13 3BE
Firmenbuch-Nummer 10689343 Companies House Eintrag ansehen
FB StatusIn Administration
Gründungsdatum24. März 2017
JahresabschlussFULL
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 2. März 2019
Branche (ÖNACE)47710 - Einzelhandel mit Bekleidung
Vorherige Namen
  • AB Retail Stores Limited
  • KYC Check
    KYC / PEP / AML-Abfrage
    Diese Daten sind inkorrekt?
    Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

    Schnellzugriff

    Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

    Quelle: Companies House
    gb-flag GB Banbury Street Six Limited Status: Aktiv Eintragung: 19.11.2021 Companies House Nummer: 13730539 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Ewm (2011) Limited Status: Inaktiv Eintragung: 24.03.2017 Löschung: 28.02.2020 Companies House Nummer: Sc396749 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Ewm (2011) Limited Status: Inaktiv Eintragung: 02.06.2021 Löschung: 19.11.2021 Companies House Nummer: Sc396749 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • gb-flag GB Ewm (Topco) Limited Status: Inaktiv Eintragung: 28.02.2020 Löschung: 02.06.2021 Companies House Nummer: 04542352 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares 75 to 100 percent as firm
  • Voting rights 75 to 100 percent as firm
  • Officers (4)

    Quelle: Companies House
    Carruthers, June The Drive, Brentwood, Essex Status: Aktiv Eintragung: 24.03.2017 Rolle: Secretary
    Herring, John Anthony The Drive, Brentwood, Essex Status: Aktiv Eintragung: 14.12.2017 Geburtsdatum: 11.1957 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Leigh, Carmel The Drive, Brentwood, Essex Status: Aktiv Eintragung: 19.02.2018 Geburtsdatum: 10.1962 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Simpson, Stephen Robert The Drive, Brentwood, Essex Status: Aktiv Eintragung: 10.05.2017 Geburtsdatum: 08.1968 Beschäftigung: Commercial Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British