UID-Suche.at

UID-Suche


Alle Informationen zu:

                        
Name

Park Lane America Holdings Limited

Adresse
Beaufort Court
Egg Farm Lane
Kings Langley
WD4 8LR
VAT ID (UID-Nummer) keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer 01389155 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschlussfull
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Oktober 2021
Branche (ÖNACE)64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Statusactive
Vorherige Namen
  • SIR Robert Mcalpine Enterprises Limited
  • KYC Check
    KYC / PEP / AML-Abfrage
    Diese Daten sind inkorrekt?
    Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

    Schnellzugriff

    Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

    Quelle: Companies House
    gb-flag GB Res Group Ventures Limited Status: Aktiv Eintragung: 19.03.2024 Companies House Nummer: 15494728 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Newarthill Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 19.03.2024 Companies House Nummer: 01050970 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • Officers (17)

    Quelle: Companies House
    Beard, Elizabeth Carol Hemel Hempstead, Hertfordshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 14.01.2013 Rolle: Secretary Nationalität: British
    Hearth, Dominic James Kings Langley, England Status: Aktiv Eintragung: 19.03.2024 Rolle: Secretary
    Mcalpine, Andrew William Hemel Hempstead, Hertfordshire Status: Aktiv Eintragung: 06.06.1991 Geburtsdatum: 11.1960 Beschäftigung: Civil Engineering & Rolle: Director Nationalität: British
    Mcalpine, David Malcolm Hemel Hempstead, Hertfordshire Status: Aktiv Eintragung: 06.06.1991 Geburtsdatum: 10.1946 Beschäftigung: Civil Engineering & Building Contractor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Mcalpine, Hector George Hemel Hempstead, Hertfordshire Status: Aktiv Eintragung: 21.01.2010 Geburtsdatum: 05.1980 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Patel, Mitesh Raj Kings Langley, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 19.03.2024 Beschäftigung: Group Financial Controller Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Mcalpine, Adrian Neil Raeburn Hemel Hempstead Status: Inaktiv Eintragung: 06.06.1991 Löschung: 23.02.2024 Geburtsdatum: 12.1944 Beschäftigung: Property Executive Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Mcalpine, Andrew William, Sir Hemel Hempstead Status: Inaktiv Löschung: 23.02.2024 Beschäftigung: Civil Engineering & Rolle: Director Nationalität: British
    Mcalpine, Cullum Hemel Hempstead Status: Inaktiv Eintragung: 06.06.1991 Löschung: 23.02.2024 Geburtsdatum: 01.1947 Beschäftigung: Civil Engineering & Building Contractor Rolle: Director Nationalität: British
    Mcalpine, David Malcolm, The Hon Hemel Hempstead Status: Inaktiv Löschung: 23.02.2024 Beschäftigung: Civil Engineering & Building Contractor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Mcalpine, Douglas James Hemel Hempstead, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 01.11.2016 Löschung: 23.02.2024 Geburtsdatum: 02.1983 Beschäftigung: Manager, Demand Side Management, America, Manager, Demand Side Management, Americas Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Mcalpine, Gavin Malcolm Egg Farm Lane Off Station Road, Kings Langley Status: Inaktiv Eintragung: 26.04.2007 Löschung: 23.02.2024 Geburtsdatum: 02.1966 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Nationalität: British
    Mcalpine, Ian Malcolm Hemel Hempstead Status: Inaktiv Eintragung: 06.06.1991 Löschung: 23.02.2024 Geburtsdatum: 04.1942 Beschäftigung: Building & Civil Engineering Contractor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Mcalpine, Richard Hugh Hemel Hempstead Status: Inaktiv Eintragung: 06.06.1991 Löschung: 23.02.2024 Geburtsdatum: 04.1958 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Nationalität: British
    Mcalpine, Robert Edward Thomas William Hemel Hempstead Status: Inaktiv Eintragung: 21.01.2010 Löschung: 23.02.2024 Geburtsdatum: 08.1978 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Pearson, Kevin John Hemel Hempstead, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 26.06.2013 Löschung: 21.05.2024 Rolle: Secretary
    Wotherspoon, Robert John William Hemel Hempstead, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 16.01.2018 Löschung: 19.03.2024 Geburtsdatum: 01.1967 Beschäftigung: Chartered Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

    Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (6)

    gb-flag GB Winner Developments Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 02319285 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%
  • Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
  • gb-flag Abacus Developments LTD Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 29.02.2024 Companies House Nummer: 01038942 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • Significant influence or control
  • gb-flag Axis Land Partnerships Limited Status: Inaktiv Eintragung: 18.07.2016 Löschung: 19.03.2024 Companies House Nummer: 10284645 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Constructenergy Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 19.03.2024 Companies House Nummer: 01498746 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Mcaulay Holdings Limited Status: Inaktiv Eintragung: 24.08.2020 Löschung: 19.03.2024 Companies House Nummer: 12832082 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag Uklp Gore Street Limited Status: Inaktiv Eintragung: 28.04.2017 Löschung: 27.05.2022 Companies House Nummer: 09716816 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%