UID-Suche.at

UID-Suche


Alle Informationen zu:

                        
Name

Taylor Wimpey UK Limited

Adresse
Gate House
Turnpike Road
High Wycombe
HP12 3NR
VAT ID (UID-Nummer) keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer 01392762 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschlussfull
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2022
Branche (ÖNACE)41100 - Erschließung von Grundstücken; Bauträger
FB Statusactive
Vorherige Namen
  • George Wimpey UK Limited
  • KYC Check
    KYC / PEP / AML-Abfrage
    Diese Daten sind inkorrekt?
    Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

    Schnellzugriff

    Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

    Quelle: Companies House
    gb-flag GB Taylor Wimpey Developments Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 00643420 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • Officers (10)

    Quelle: Companies House
    Billson-Ross, Katherine Anne High Wycombe, Buckinghamshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 18.11.2014 Geburtsdatum: 11.1968 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Bishop, Lee Michael High Wycombe, Buckinghamshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 02.01.2015 Geburtsdatum: 08.1965 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Carney, Christopher High Wycombe, Buckinghamshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 22.07.2015 Geburtsdatum: 05.1974 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Daly, Jennifer High Wycombe, Buckinghamshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 22.07.2015 Geburtsdatum: 04.1970 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Drummond, Ian Scott Dumfermline, Fife, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 26.11.2020 Geburtsdatum: 08.1976 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Holland, Nigel Almondsbury, Bristol, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 22.07.2015 Geburtsdatum: 09.1960 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Kayani, Muhammed Ishaq High Wycombe, Bucks, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 21.02.2023 Rolle: Secretary
    Kayani, Muhammed Ishaq High Wycombe, Bucks, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 21.02.2023 Geburtsdatum: 05.1973 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Osborne, Ingrid Ruth High Wycombe, Buckinghamshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2013 Geburtsdatum: 09.1977 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    White, Shaun Roland High Wycombe, Buckinghamshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 26.11.2020 Geburtsdatum: 04.1973 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

    Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (10)

    gb-flag GB Bronze Park Resident Management Company Limited Status: Aktiv Eintragung: 01.05.2024 Companies House Nummer: 15698298 Art der Kontrolle
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • gb-flag GB Buckton Fields (Northampton) Apartment Management Company Limited Status: Aktiv Eintragung: 24.10.2022 Companies House Nummer: 14437698 Art der Kontrolle
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Buckton Fields (Northampton) Estate Management Company Limited Status: Aktiv Eintragung: 24.10.2022 Companies House Nummer: 14437853 Art der Kontrolle
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Cotswold View Residents Association Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 03876157 Art der Kontrolle
  • Significant influence or control
  • gb-flag GB Regency Place (Shiplake) Management Company Limited Status: Aktiv Eintragung: 21.10.2019 Companies House Nummer: 12273645 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • gb-flag GB Romans Gate (OLD Stratford) Residents Association Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 04955221 Art der Kontrolle
  • Significant influence or control
  • gb-flag GB ST Aubyn Park Management Company Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 08570550 Art der Kontrolle
  • Significant influence or control
  • gb-flag GB Telford Millennium Management Company Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 06449700 Art der Kontrolle
  • Significant influence or control
  • gb-flag GB Whitehouse Farm Apartments (Emersons Green) Management Company Limited Status: Aktiv Eintragung: 20.04.2022 Companies House Nummer: 14056337 Art der Kontrolle
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Woodside Vale (Leeds) Residents Management Company Limited Status: Aktiv Eintragung: 13.10.2022 Companies House Nummer: 14416236 Art der Kontrolle
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors