UID-Suche.at

UID-Suche


Alle Informationen zu:

                        
Name

Lendlease Construction (Europe) Limited

Adresse
19 St Aubyns Avenue
Hounslow
TW3 3TG
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
Beginn der Umsatzsteuer Registrierung
24. August 2022
Ende der Umsatzsteuer Registrierung
12. Oktober 2023
FB Name Bovis Construction (Europe) Limited
FB Adresse 30 Crown Place
London
EC2A 4ES
Firmenbuch-Nummer 00467006 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschlussfull
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2022
Branche (ÖNACE)41201 - Bau von Gebäuden
FB Statusactive
Vorherige Namen
  • Lend Lease Construction (Emea) Limited
  • Bovis Lend Lease Limited
  • KYC Check
    KYC / PEP / AML-Abfrage
    Diese Daten sind inkorrekt?
    Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

    Schnellzugriff

    Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

    Quelle: Companies House
    gb-flag GB Lendlease Construction Holdings (Europe) Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 00231889 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • Officers (15)

    Quelle: Companies House
    Cadiot, David Edward Level 9, London, England Status: Aktiv Eintragung: 07.04.2021 Geburtsdatum: 02.1977 Beschäftigung: Executive General Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Gillibrand, Tom Level 9, London, England Status: Aktiv Eintragung: 24.03.2023 Geburtsdatum: 04.1986 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Losyk, Jonathan David Peter Level 9, London, England Status: Aktiv Eintragung: 28.04.2021 Geburtsdatum: 08.1965 Beschäftigung: Commercial Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Mackay, Andrew Level 9, London, England Status: Aktiv Eintragung: 10.10.2024 Beschäftigung: General Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Pearce, James Robert Level 9, London, England Status: Aktiv Eintragung: 12.08.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Gledhill, Lisa Veronica Regent'S Place, London Status: Inaktiv Eintragung: 10.05.2013 Löschung: 22.06.2016 Beschäftigung: General Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Gorski, Simon William Level 9, London, England Status: Inaktiv Eintragung: 07.06.2016 Löschung: 23.08.2024 Geburtsdatum: 09.1969 Beschäftigung: Executive General Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Kondo, Glenn Regent'S Place, London, England Status: Inaktiv Eintragung: 05.11.2010 Löschung: 04.10.2011 Beschäftigung: Chief Financial Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Canadian,British
    Kotecha, Shaina Level 9, London, England Status: Inaktiv Eintragung: 13.10.2020 Löschung: 07.06.2024 Geburtsdatum: 07.1969 Beschäftigung: Head Of People And Culture, Europe Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Labbad, Daniel Regent'S Place, London Status: Inaktiv Eintragung: 26.06.2018 Löschung: 30.09.2019 Beschäftigung: Chief Executive Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Australian,British
    Leonard, Peter Dominic Regent'S Place, London Status: Inaktiv Eintragung: 09.10.2017 Löschung: 18.02.2021 Beschäftigung: Commercial Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Martin, Neil Christopher Level 9, London, England Status: Inaktiv Eintragung: 24.03.2014 Löschung: 08.08.2023 Beschäftigung: Md Construction Lend Lease Emea Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Pettett, Claire Marianne Level 9, London, England Status: Inaktiv Eintragung: 20.02.2018 Löschung: 04.10.2024 Geburtsdatum: 09.1975 Beschäftigung: Chartered Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Quinlan, Victoria Elizabeth Regent'S Place, London, England Status: Inaktiv Eintragung: 19.12.2012 Löschung: 11.06.2021 Beschäftigung: Operations Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Australian
    Seeley, Rebecca Jayne Level 9, London, England Status: Inaktiv Eintragung: 13.07.2020 Löschung: 29.09.2023 Geburtsdatum: 04.1980 Beschäftigung: Commercial Director, Development Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

    Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (9)

    gb-flag GB BLS Blackfriars Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 05144014 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%
  • Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
  • gb-flag GB Coleman Street Developments Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 05278531 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%
  • Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
  • gb-flag GB Blfb Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 02.12.2024 Companies House Nummer: 05613052 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Debut Services (Contracts) LTD Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 20.02.2025 Companies House Nummer: 04905429 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag Debut Services (South West) LTD Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 20.02.2025 Companies House Nummer: 04582950 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%
  • Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag Debut Services Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 20.02.2025 Companies House Nummer: 04182322 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag Elwick Place Construction Limited Status: Inaktiv Eintragung: 10.04.2017 Löschung: 17.12.2024 Companies House Nummer: 10347177 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%
  • Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
  • gb-flag GB Lendlease Construction Management Services (ONE) Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 02.12.2024 Companies House Nummer: 03442721 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Lendlease Construction North Western Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 02.12.2024 Companies House Nummer: 00989307 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors