UID-Suche.at

UID-Suche


Alle Informationen zu:

                        
Name

Infraco Africa Investment Limited

Adresse
6 Bevis Marks
London
EC3A 7BA
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
Beginn der Umsatzsteuer Registrierung
12. Mai 2016
Firmenbuch-Nummer 09152403 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschlusssmall
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2022
Branche (ÖNACE)82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
FB Statusactive
KYC Check
KYC / PEP / AML-Abfrage
Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (8)

Quelle: Companies House
gb-flag GB Sg Kleinwort Hambros Trust Company Uk Limited Status: Aktiv Eintragung: 21.03.2019 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares 75 to 100 percent as trust
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors as trust
  • gb-flag GB The Private Infrastructure Development Group Limited Status: Aktiv Eintragung: 08.08.2018 Companies House Nummer: 11265124 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Iq Eq Trustees (Mauritius) Ltd Status: Inaktiv Eintragung: 01.12.2021 Löschung: 27.06.2023 Companies House Nummer: C24811 Art der Kontrolle
  • Voting rights 75 to 100 percent as trust
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Marriott Davies Yapp Llp Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 08.08.2018 Companies House Nummer: Oc370966 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares 75 to 100 percent as trust
  • Voting rights 75 to 100 percent as trust
  • Right to appoint and remove directors as trust
  • gb-flag GB Minimax Ltd Status: Inaktiv Eintragung: 21.03.2019 Löschung: 20.11.2021 Companies House Nummer: N/A Art der Kontrolle
  • Ownership of shares 75 to 100 percent as trust
  • Voting rights 75 to 100 percent as trust
  • Right to appoint and remove directors as trust
  • gb-flag GB Minimax Ltd Status: Inaktiv Eintragung: 21.11.2021 Löschung: 27.06.2023 Companies House Nummer: C11099 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares 75 to 100 percent as trust
  • Voting rights 75 to 100 percent as trust
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Multiconsult Trustees Ltd Status: Inaktiv Eintragung: 21.03.2019 Löschung: 30.11.2021 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares 75 to 100 percent as trust
  • Voting rights 75 to 100 percent as trust
  • Right to appoint and remove directors as trust
  • gb-flag GB The Private Infrastructure Group Limited Status: Inaktiv Eintragung: 20.11.2021 Löschung: 19.05.2022 Companies House Nummer: 00514879 Art der Kontrolle
  • Significant influence or control
  • Officers (6)

    Quelle: Companies House
    Chilton, Michael Barry London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 02.10.2018 Geburtsdatum: 09.1964 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Lim Hsi-Yun, Claudine London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 28.06.2022 Geburtsdatum: 01.1967 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Singapore Nationalität: Singaporean
    Vaes, Gilles London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 16.06.2022 Geburtsdatum: 09.1971 Beschäftigung: Ceo Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Belgium Nationalität: Belgian
    Vistra Company Secretaries Limited, 10 Temple Back, Bristol Status: Aktiv Eintragung: 29.07.2014 Rolle: Secretary Nationalität: British
    Makoni, Tinashe London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 01.05.2022 Löschung: 10.05.2024 Geburtsdatum: 08.1981 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Songini, Tania Louise London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 02.10.2018 Löschung: 30.04.2022 Beschäftigung: Non-Executive Director, Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British