UID-Suche.at

UID-Suche


Alle Informationen zu:

                        
Name

Carboclass Limited

Adresse
Unit 1 Radford Industrial Estate
Goodhall Street
London
NW10 6UA
VAT ID (UID-Nummer) keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer 01906203 Companies House Eintrag ansehen
FB Status aktiv
Gründungsdatum18. April 1985
JahresabschlussFULL
nächster Jahresabschluss fällig bis 30. September 2023
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)47520 - Einzelhandel mit Metallwaren, Anstrichmitteln, Bau- und Heimwerkerbedarf
KYC Check
KYC / PEP / AML-Abfrage
Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House
gb-flag GB Lords Builders Merchants Holdings Limited Status: Aktiv Eintragung: 05.01.2024 Companies House Nummer: 10058191 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Fastlane Investments Ltd Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 05.01.2024 Companies House Nummer: 03619301 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • Patel, Shanker Bhupendrabhai Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 02.1971 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%
  • Officers (7)

    Quelle: Companies House
    Bath, Steve Goodhall Street, London Status: Aktiv Eintragung: 01.10.2019 Geburtsdatum: 08.1969 Beschäftigung: Purchasing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Herd, James Goodhall Street, London Status: Aktiv Eintragung: 01.06.2020 Geburtsdatum: 01.1980 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Patel, Nilesh Rasikbhai Goodhall Street, London Status: Aktiv Eintragung: 22.08.1992 Geburtsdatum: 02.1958 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Patel, Rajen Bhupendrabhai Goodhall Street, London Status: Aktiv Eintragung: 19.07.2004 Geburtsdatum: 10.1966 Beschäftigung: Finance Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Patel, Shanker Bhupendrabhai Goodhall Street, London Status: Aktiv Eintragung: 14.06.1999 Geburtsdatum: 02.1971 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Price, Darren Nicholas Goodhall Street, London Status: Aktiv Eintragung: 01.06.2023 Geburtsdatum: 09.1973 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Day, Christopher Michael Goodhall Street, London Status: Inaktiv Eintragung: 01.10.2019 Löschung: 17.05.2024 Geburtsdatum: 03.1984 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

    Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (10)

    gb-flag Advance Roofing Supplies LTD Status: Aktiv Eintragung: 05.01.2022 Companies House Nummer: 02971503 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Alloway Holdings Limited Status: Aktiv Eintragung: 01.09.2023 Companies House Nummer: 12540950 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Alloway Properties Limited Status: Aktiv Eintragung: 13.12.2023 Companies House Nummer: 12552646 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag Chiltern Timber Supplies Limited Status: Aktiv Eintragung: 31.03.2023 Companies House Nummer: 08415193 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag Condell LTD Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2021 Companies House Nummer: 05701638 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB E.Hussey & Sons Limited Status: Aktiv Eintragung: 04.01.2017 Companies House Nummer: 00757302 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB George Lines (Merchants) Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 00469855 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag Hevey Building Supplies LTD Status: Aktiv Eintragung: 27.10.2017 Companies House Nummer: 04251567 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Kings Langley Building Supplies Limited Status: Aktiv Eintragung: 03.09.2018 Companies House Nummer: 01379046 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Newstore Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 03856066 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors