UID-Suche.at

UID-Suche


Alle Informationen zu:

                        
Name

Awrp Holding CO Limited

Adresse
141 Park Drive
Milton Park Milton
Abingdon
OX14 4SE
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
Beginn der Umsatzsteuer Registrierung
11. Mai 2016
FB Adresse 3rd Floor 3-5 Charlotte Street
Manchester
M1 4HB
Firmenbuch-Nummer 08717836 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschlussgroup
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Statusactive
Vorherige Namen
  • Ameycespa (Awrp) Holding CO Limited
  • KYC Check
    KYC / PEP / AML-Abfrage
    Diese Daten sind inkorrekt?
    Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

    Schnellzugriff

    Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

    Quelle: Companies House
    gb-flag GB Equitix Concessions 3 Ltd Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 08874528 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%
  • Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
  • gb-flag GB Equitix Infrastructure Management (2) Limited Status: Aktiv Eintragung: 09.01.2019 Companies House Nummer: 11488363 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%
  • Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
  • gb-flag GB Pip Infrastructure Investments (No 5) Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 08063001 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%
  • Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
  • Officers (9)

    Quelle: Companies House
    Albany Secretariat Limited, Manchester, England Status: Aktiv Eintragung: 20.04.2023 Rolle: Secretary
    Knight, Richard Daniel London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 28.10.2014 Geburtsdatum: 01.1974 Beschäftigung: Operations Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Kyle, Roy London, England Status: Aktiv Eintragung: 28.02.2023 Geburtsdatum: 02.1961 Beschäftigung: Senior Portfolio Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Mihill, Timothy James London, England Status: Aktiv Eintragung: 15.01.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Price, Alexander London, England Status: Aktiv Eintragung: 22.09.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Cohen, Gershon Daniel 1 Bread Street, London, England Status: Inaktiv Eintragung: 29.01.2015 Löschung: 09.05.2017 Beschäftigung: Head Of Infrastructure Funds Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Skerman, Philip Arthur London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 13.07.2020 Löschung: 22.09.2023 Geburtsdatum: 02.1988 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Australian
    Thakrar, Amit Rishi Jaysukh 32 London Bridge Street, London, England Status: Inaktiv Eintragung: 31.03.2022 Löschung: 28.02.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Wilson, Edward Arthur London, England Status: Inaktiv Eintragung: 06.12.2017 Löschung: 15.01.2024 Geburtsdatum: 12.1965 Beschäftigung: Chief Investment Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

    Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

    gb-flag GB Awrp SPV Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 08717850