UID-Suche.at

UID-Suche


Alle Informationen zu:

                        
Name

Charnwood Molecular Limited

Adresse
The Heritage Building
7 Beaumont Court
Prince William Road
Loughborough
LE11 5GA
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
Ende der Umsatzsteuer Registrierung
27. März 2020
FB Adresse Building 42 Charnwood Campus
Loughborough
LE11 5RD
Firmenbuch-Nummer 03550782 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschlussfull
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Juli 2022
Branche (ÖNACE)72110 - Forschung und Entwicklung im Bereich Biotechnologie
FB Statusactive
KYC Check
KYC / PEP / AML-Abfrage
Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House
gb-flag GB Maxwell Bidco Limited Status: Aktiv Eintragung: 13.12.2019 Companies House Nummer: 12251742 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB W8s Directors Limited Status: Aktiv Eintragung: 04.05.2024 Companies House Nummer: 14733769 Art der Kontrolle
  • Significant influence or control
  • Allin, Steven Mark Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 13.12.2019 Geburtsdatum: 08.1968 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%
  • Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
  • Page, Philip Charles Bulman Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 13.12.2019 Geburtsdatum: 12.1955 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%
  • Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
  • Officers (8)

    Quelle: Companies House
    Cons, Ben Major George 9 Summerpool Road, Loughborough, Leicestershire, England Status: Aktiv Eintragung: 17.10.2022 Geburtsdatum: 03.1966 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    gb-flag GB Cossey Cosec Services Limited 24 Old Bond Street, London, United Kingdom, W1S 4AW Status: Aktiv Eintragung: 04.05.2024 Rolle: Corporate-Secretary Companies House Nummer: 14344691
    Hitchin, James Richard, Dr 9 Summerpool Road, Loughborough, England Status: Aktiv Eintragung: 22.08.2024 Beschäftigung: Chief Operating Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Nolan, Trevor Frank Nottingham, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 02.06.2020 Geburtsdatum: 04.1973 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Patterson, Lee Robert 9 Summerpool Road, Loughborough, Leicestershire, England Status: Aktiv Eintragung: 28.07.2022 Geburtsdatum: 06.1973 Beschäftigung: Chief Executive Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Sadler, Francesca Anne, Dr 9 Summerpool Road, Loughborough, England Status: Aktiv Eintragung: 22.08.2024 Beschäftigung: Chief Commercial Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    gb-flag GB W8s Directors Limited 24 Old Bond Street, Mayfair, London, United Kingdom, W1S 4AW Status: Aktiv Eintragung: 04.05.2024 Rolle: Corporate-Director Companies House Nummer: 14733769
    Cons, Ben Major George, Dr 9 Summerpool Road, Loughborough, England Status: Inaktiv Eintragung: 17.10.2022 Löschung: 04.05.2024 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

    Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

    gb-flag Aurelia Bioscience LTD Status: Aktiv Eintragung: 14.06.2021 Companies House Nummer: 07657187 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors