UID-Suche.at

UID-Suche


Alle Informationen zu:

                        
Name

Trimite Limited

Adresse
2E
Eagle Road
Moons Moat North Industrial
Redditch
B98 9HF
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
Beginn der Umsatzsteuer Registrierung
15. Mai 2016
Firmenbuch-Nummer 01564257 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschlusssmall
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)20301 - Herstellung von Anstrichmitteln, Druckfarben und Kitten
FB Statusactive
Vorherige Namen
  • Weilburger Coatings (UK) Limited
  • Trimite Limited | Trimite
  • Weilburger Schramm Coatings (UK) Limited
  • KYC Check
    KYC / PEP / AML-Abfrage
    Diese Daten sind inkorrekt?
    Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

    Schnellzugriff

    Personen mit signifikanter Kontrolle (7)

    Quelle: Companies House
    gb-flag GB Trimite Bid Co Limited Status: Aktiv Eintragung: 02.03.2018 Companies House Nummer: 11060343 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • Cid De La Paz, William Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 02.03.2018 Geburtsdatum: 11.1958 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares 25 to 50 percent as trust
  • Voting rights 25 to 50 percent as trust
  • Cuby, David Denis Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 02.03.2018 Geburtsdatum: 05.1948 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares 25 to 50 percent as trust
  • Voting rights 25 to 50 percent as trust
  • Hassan, James David Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 02.03.2018 Geburtsdatum: 11.1946 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares 25 to 50 percent as trust
  • Voting rights 25 to 50 percent as trust
  • Malkani, Subash Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 02.03.2018 Geburtsdatum: 05.1955 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares 25 to 50 percent as trust
  • Voting rights 25 to 50 percent as trust
  • Olivero, Adrian Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 02.03.2018 Geburtsdatum: 05.1967 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares 25 to 50 percent as trust
  • Voting rights 25 to 50 percent as trust
  • Perera, Maurice Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 02.03.2018 Geburtsdatum: 10.1961 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares 25 to 50 percent as trust
  • Voting rights 25 to 50 percent as trust
  • Officers (5)

    Quelle: Companies House
    gb-flag GB Higgs Secretarial Limited Waterfront Business Park, Dudley Road, Brierley Hill, England, DY5 1LX Status: Aktiv Eintragung: 06.11.2023 Rolle: Corporate-Secretary Companies House Nummer: 05451895
    Smith, Nigel Ernest Moons Moat North Industrial Estate, Redditch, England Status: Aktiv Eintragung: 31.01.2024 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Westwood, Thomas Philip Moons Moat North Industrial Estate, Redditch, England Status: Aktiv Eintragung: 31.01.2024 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Cobb, Martin Moons Moat North Industrial Estate, Redditch, England Status: Inaktiv Eintragung: 10.12.2021 Löschung: 31.01.2024 Geburtsdatum: 04.1988 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Thornhill, Stephen Paul Moons Moat North Industrial Estate, Redditch, England Status: Inaktiv Eintragung: 13.11.2020 Löschung: 31.01.2024 Geburtsdatum: 10.1964 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Portugal Nationalität: English