UID-Suche.at

UID-Suche


Alle Informationen zu:

                        
Name

Elivia Homes Limited

Adresse
Apollo House
Mercury Park
Wycombe Lane
Wooburn Green
HP10 0HH
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
Beginn der Umsatzsteuer Registrierung
11. Mai 2016
Firmenbuch-Nummer 05011077 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschlussaudit-exemption-subsidiary
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2022
Branche (ÖNACE)41100 - Erschließung von Grundstücken; Bauträger
FB Statusactive
Vorherige Namen
  • Vanderbilt Homes Limited
  • Vanderbilt Thames Valley Limited
  • KYC Check
    KYC / PEP / AML-Abfrage
    Diese Daten sind inkorrekt?
    Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

    Schnellzugriff

    Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

    Quelle: Companies House
    gb-flag GB Elivia Development Finance Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 08599295 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • Spencer-Churchill, Edward Albert Charles Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 09.03.2018 Geburtsdatum: 08.1974 Art der Kontrolle
  • Significant influence or control
  • Spencer-Churchill, Rupert Mark Harold John Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 09.03.2017 Geburtsdatum: 11.1971 Art der Kontrolle
  • Significant influence or control
  • Officers (4)

    Quelle: Companies House
    Armstrong, Robin William Alexander Wycombe Lane, Wooburn Green, Buckinghamshire Status: Aktiv Eintragung: 01.05.2023 Rolle: Secretary
    Brown, Iain Mitchell Wycombe Lane, Wooburn Green Status: Aktiv Eintragung: 30.05.2017 Geburtsdatum: 07.1972 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Chiles, Christopher Wycombe Lane, Wooburn Green, Buckinghamshire Status: Aktiv Eintragung: 28.09.2016 Geburtsdatum: 11.1969 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Spencer Churchill, Rupert Mark Harold John Wycombe Lane, Wooburn Green, England Status: Inaktiv Eintragung: 09.01.2004 Löschung: 01.03.2018 Beschäftigung: Property Developer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

    Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (10)

    gb-flag Crayfern Homes (South Coast) Limited Status: Aktiv Eintragung: 11.07.2019 Companies House Nummer: 09662969 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag Crayfern Homes LTD Status: Aktiv Eintragung: 11.07.2019 Companies House Nummer: 02703219 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Crayfern Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 08733415 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Elivia Homes (Central) Limited Status: Aktiv Eintragung: 29.03.2018 Companies House Nummer: 08599290 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Elivia Southern Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 06994546 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Hunters Chase (Haslemere) Residents Management Company Limited Status: Aktiv Eintragung: 21.07.2023 Companies House Nummer: 15019982 Art der Kontrolle
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB MDH (Group) Limited Status: Aktiv Eintragung: 31.10.2023 Companies House Nummer: 09096398 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Sadler's Court (Preston) Management Company Limited Status: Aktiv Eintragung: 12.04.2024 Companies House Nummer: 15639579 Art der Kontrolle
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Southwater (Shipley Road) Residents Management Company Limited Status: Aktiv Eintragung: 30.11.2023 Companies House Nummer: 15320391 Art der Kontrolle
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag Vanderbilt Oxford LTD Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 05951266 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors