UID-Suche.at

UID-Suche


Alle Informationen zu:

                        
Name

Coaltown Limited

Adresse
Foundry Road
Ammanford
Dyfed
SA18 2LS
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
Beginn der Umsatzsteuer Registrierung
10. Mai 2016
Firmenbuch-Nummer 08501140 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschlusstotal-exemption-full
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. April 2022
Branche (ÖNACE)10832 - Verarbeitung von Kaffee und Tee, Herstellung von Kaffee-Ersatz
FB Statusactive
Vorherige Namen
  • Roasted Joe's Coffee Company Limited | Roasted Joe's Coffee
  • Roasted Joe's Coffee Company Limited
  • KYC Check
    KYC / PEP / AML-Abfrage
    Diese Daten sind inkorrekt?
    Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

    Schnellzugriff

    Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

    Quelle: Companies House
    gb-flag GB Sieffre Holdings Limited Status: Aktiv Eintragung: 25.06.2019 Companies House Nummer: 10992456 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • James, Gordon Angus Status: Inaktiv Eintragung: 25.06.2019 Löschung: 25.06.2019 Geburtsdatum: 11.1965 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%
  • Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
  • James, Gordon Scott Status: Inaktiv Eintragung: 25.06.2019 Löschung: 25.06.2019 Geburtsdatum: 06.1993 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%
  • Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
  • James, Paula Jennine Status: Inaktiv Eintragung: 01.01.2017 Löschung: 25.06.2019 Geburtsdatum: 04.1968 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%
  • Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
  • James, Paula Jennine Status: Inaktiv Eintragung: 18.06.2018 Löschung: 25.06.2019 Geburtsdatum: 04.1968 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%
  • Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%
  • Right to appoint and remove directors
  • Officers (6)

    Quelle: Companies House
    Clarke, Joshua Luke Hamblin Ammanford, Carmarthenshire, Wales Status: Aktiv Eintragung: 13.06.2022 Geburtsdatum: 03.1991 Beschäftigung: Director Of Coffee Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British
    Haimes, Nicholas Stewart Ammanford, Carmarthenshire, Wales Status: Aktiv Eintragung: 25.04.2022 Geburtsdatum: 03.1988 Beschäftigung: Director Of Brand & Ecommerce Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British
    James, Gordon Angus Ammanford, Carmarthenshire, Wales Status: Aktiv Eintragung: 01.03.2014 Geburtsdatum: 11.1965 Beschäftigung: Architect Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    James, Gordon Scott Ammanford, Carmarthenshire, Wales Status: Aktiv Eintragung: 27.02.2018 Geburtsdatum: 06.1993 Beschäftigung: Founder Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British
    James, Paula Jennine Ammanford, Carmarthenshire, Wales Status: Aktiv Eintragung: 04.07.2013 Geburtsdatum: 04.1968 Beschäftigung: Company Secretary/director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    James, Paula Jennine Ammanford, Carmarthenshire, Wales Status: Aktiv Eintragung: 23.04.2013 Rolle: Secretary