UID-Suche.at

UID-Suche


Alle Informationen zu:

                        
Name

C P Holdings LTD

Adresse
C P House
Otterspool Way
Watford By Pass
Watford
WD25 8HG
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
Beginn der Umsatzsteuer Registrierung
12. Mai 2016
FB Name CP Holdings Limited
FB Adresse Cp House
Watford
WD25 8JJ
Firmenbuch-Nummer 00580471 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschlussgroup
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)70100 - Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben
FB Statusactive
KYC Check
KYC / PEP / AML-Abfrage
Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (9)

Quelle: Companies House
Gibbor, Iris Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 08.1951 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%
  • Schreier, Alexei James Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 10.1976 Art der Kontrolle
  • Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
  • Denton, Richard Mark Status: Inaktiv Eintragung: 06.02.2020 Löschung: 30.11.2023 Geburtsdatum: 08.1972 Art der Kontrolle
  • Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
  • Gibbor, Mark Adam Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 30.11.2023 Geburtsdatum: 07.1988 Art der Kontrolle
  • Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
  • Glatter, Robert Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 20.03.2023 Geburtsdatum: 03.1937 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares 25 to 50 percent as trust
  • Voting rights 25 to 50 percent as trust
  • Gorey, Catherine Anne Status: Inaktiv Eintragung: 06.02.2020 Löschung: 30.11.2023 Geburtsdatum: 08.1980 Art der Kontrolle
  • Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
  • Levy, Robert Michael Status: Inaktiv Eintragung: 20.03.2023 Löschung: 30.11.2023 Geburtsdatum: 07.1954 Art der Kontrolle
  • Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
  • Schreier, Lilly Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 10.03.2019 Geburtsdatum: 07.1924 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%
  • Ownership of shares 50 to 75 percent as trust
  • Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%
  • Voting rights 50 to 75 percent as trust
  • Wreschner, Michael Montague Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 30.11.2023 Geburtsdatum: 09.1944 Art der Kontrolle
  • Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
  • Officers (10)

    Quelle: Companies House
    Dudley-Scales, Claire Watford, Hertfordshire Status: Aktiv Eintragung: 26.08.2021 Geburtsdatum: 05.1976 Beschäftigung: Chartered Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Gibbor, Iris Watford, Hertfordshire Status: Aktiv Eintragung: 23.02.1998 Geburtsdatum: 08.1951 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Gibbor, Mark Adam Watford Status: Aktiv Eintragung: 23.01.2014 Geburtsdatum: 07.1988 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Hennebry, Mark Watford, Hertfordshire Status: Aktiv Eintragung: 04.03.2015 Geburtsdatum: 03.1966 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Ireland Nationalität: Irish
    Hirst Obe, Michael Barry Watford, Hertfordshire Status: Aktiv Eintragung: 22.01.2015 Geburtsdatum: 07.1943 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Hoffbrand, Philip Watford, Hertfordshire Status: Aktiv Eintragung: 05.09.2012 Geburtsdatum: 05.1967 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Lewis, Eric Watford, Hertfordshire Status: Aktiv Eintragung: 01.01.1992 Geburtsdatum: 07.1927 Beschäftigung: Solicitor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Schreier, Alexei James Watford, Hertfordshire Status: Aktiv Eintragung: 27.09.2005 Geburtsdatum: 10.1976 Beschäftigung: Executive Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Sheridan, Andrew Paul Watford, Hertfordshire Status: Aktiv Eintragung: 22.12.2020 Geburtsdatum: 12.1964 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Smith, John Ernest Watford, Hertfordshire Status: Aktiv Eintragung: 01.01.1992 Geburtsdatum: 03.1949 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

    Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (9)

    gb-flag CP Regents Park TWO LTD Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 05307946 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Conmach Limited Status: Aktiv Eintragung: 13.04.2018 Companies House Nummer: 11309884 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Drencan Limited Status: Aktiv Eintragung: 10.08.2016 Companies House Nummer: 10322979 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%
  • Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag IP-Xchange Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 02573906 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Kingsbury Link Management Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 01342168 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag Lenta Properties LTD Status: Aktiv Eintragung: 29.11.2019 Companies House Nummer: 01548851 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Milerun Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 02589688 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB N.C.C. Minerals Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 00865659 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag T J Harman & Sons LTD Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 00499845 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors

  • Branch VAT Numbers (1)

    gb-flag Dyggor Gaylord LTDStation Rd, Ilkeston, Derby, DE7 5TU