UID-Suche.at

UID-Suche


Alle Informationen zu:

                        
Name

CP Foods (UK) LTD

Adresse
Avon House
Hartlebury Trading Estate
Hartlebury
Worcestershire
DY10 4JB
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
FB Name CP Foods (UK) Limited
FB Adresse Polonia House Enigma Commercial Centre
Malvern
WR14 1JJ
Firmenbuch-Nummer 04307559 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschlussgroup
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)46320 - Großhandel mit Fleisch und Fleischwaren
46380 - Großhandel mit sonstigen Nahrungs- und Genussmitteln
FB Statusactive
Vorherige Namen
  • Fusion Foods Limited
  • KYC Check
    KYC / PEP / AML-Abfrage
    Diese Daten sind inkorrekt?
    Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

    Schnellzugriff

    Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

    Quelle: Companies House
    gb-flag GB Charoen Pokphand Foods Pcl Status: Aktiv Eintragung: 19.10.2016 Companies House Nummer: Tba Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • gb-flag GB Cpf Europe Sa Status: Aktiv Eintragung: 19.10.2021 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Britton, Clive Status: Inaktiv Eintragung: 19.10.2016 Löschung: 02.11.2018 Geburtsdatum: 03.1964 Art der Kontrolle
  • Significant influence or control
  • Cheadle, Mark Status: Inaktiv Eintragung: 19.10.2016 Löschung: 02.11.2018 Geburtsdatum: 08.1969 Art der Kontrolle
  • Significant influence or control
  • Vincent, John Philip Status: Inaktiv Eintragung: 19.10.2016 Löschung: 02.11.2018 Geburtsdatum: 09.1962 Art der Kontrolle
  • Significant influence or control
  • Officers (8)

    Quelle: Companies House
    Browne, Timothy Philip Sandy'S Road, Malvern, England Status: Aktiv Eintragung: 01.05.2025 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Kaarunayadhorn, Parinya Sandy'S Road, Malvern, England Status: Aktiv Eintragung: 02.08.2023 Geburtsdatum: 06.1966 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Thailand Nationalität: Thai
    Singhpuck, Vathana Sandy'S Road, Malvern, Worcestershire, England Status: Aktiv Eintragung: 11.09.2020 Geburtsdatum: 09.1961 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Thailand Nationalität: Thai
    Ua-Wutthikrerk, Ekpiya Sandy'S Road, Malvern, England Status: Aktiv Eintragung: 02.08.2023 Geburtsdatum: 02.1975 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Thailand Nationalität: Thai
    Yingchankul, Sirichai Sandy'S Road, Malvern, England Status: Aktiv Eintragung: 09.05.2013 Geburtsdatum: 11.1966 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Yingchankul, Sirichai Sandy'S Road, Malvern, Worcestershire, England Status: Aktiv Eintragung: 02.11.2018 Rolle: Secretary
    Middleton, James Hartlebury, Kidderminster, England Status: Inaktiv Eintragung: 02.11.2018 Löschung: 11.09.2020 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Shaw, Nicholas Charles Sandy'S Road, Malvern, England Status: Inaktiv Eintragung: 02.11.2018 Löschung: 01.05.2025 Geburtsdatum: 01.1962 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

    Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (10)

    gb-flag GB Fusion Abbey Park Limited Status: Aktiv Eintragung: 21.12.2016 Companies House Nummer: 06035491 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • gb-flag GB Fusion Bransford Limited Status: Aktiv Eintragung: 23.02.2017 Companies House Nummer: 07165739 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • gb-flag GB Fusion Dormington Limited Status: Aktiv Eintragung: 19.12.2016 Companies House Nummer: 04622363 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • gb-flag GB Fusion Eastoe Limited Status: Aktiv Eintragung: 23.06.2017 Companies House Nummer: 07680382 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • gb-flag GB Fusion Elmbridge Limited Status: Aktiv Eintragung: 22.02.2017 Companies House Nummer: 07165654 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • gb-flag GB Fusion Exning Limited Status: Aktiv Eintragung: 10.09.2016 Companies House Nummer: 07014733 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • gb-flag GB Fusion Gatley Limited Status: Aktiv Eintragung: 13.12.2016 Companies House Nummer: 06027194 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • gb-flag GB Fusion Pershore Limited Status: Aktiv Eintragung: 07.12.2016 Companies House Nummer: 06022546 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • gb-flag GB Fusion Uzumlu Limited Status: Aktiv Eintragung: 20.10.2016 Companies House Nummer: 05973550 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • gb-flag GB Fusion Wellington Limited Status: Aktiv Eintragung: 21.11.2016 Companies House Nummer: 04596372 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more