UID-Suche.at

UID-Suche


Alle Informationen zu:

                        
Name

Firstport Group Limited

Adresse
Queensway House
11 Queensway
New Milton
BH25 5NR
VAT ID (UID-Nummer) keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer 04352396 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschlusstotal-exemption-full
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)70100 - Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben
FB Statusactive
Vorherige Namen
  • Firstport Limited
  • Peverel Property Management Limited
  • Launchcoin Limited
  • KYC Check
    KYC / PEP / AML-Abfrage
    Diese Daten sind inkorrekt?
    Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

    Schnellzugriff

    Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

    Quelle: Companies House
    gb-flag GB Drive Topco Limited Status: Aktiv Eintragung: 31.05.2023 Companies House Nummer: 12043031 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Emeria Res Uk Newco Limited Status: Inaktiv Eintragung: 31.05.2023 Löschung: 31.05.2023 Companies House Nummer: 13778359 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Knight Square Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 31.05.2023 Companies House Nummer: 07925019 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • Officers (3)

    Quelle: Companies House
    Firstport Secretarial Limited, New Milton, Hampshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 14.07.2011 Rolle: Secretary
    Perrett, Steve John 11 Queensway, New Milton, Hampshire Status: Aktiv Eintragung: 18.08.2022 Geburtsdatum: 04.1965 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Saleh, Ouda 11 Queensway, New Milton, Hampshire Status: Aktiv Eintragung: 07.06.2013 Geburtsdatum: 01.1979 Beschäftigung: Director Of Finance Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

    Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (9)

    gb-flag Alexander Faulkner Partnership Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.03.2023 Companies House Nummer: 05574453 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Burlington Estates (London) Limited Status: Aktiv Eintragung: 08.12.2023 Companies House Nummer: 07854696 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Firstport Property Services Limited Status: Aktiv Eintragung: 01.01.2018 Companies House Nummer: 02061041 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Firstport Property Services NO.10 Limited Status: Aktiv Eintragung: 31.10.2022 Companies House Nummer: 06243275 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Firstport Property Services NO.7 Limited Status: Aktiv Eintragung: 31.05.2023 Companies House Nummer: 04052477 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Firstport Property Services NO.9 Limited Status: Aktiv Eintragung: 04.10.2021 Companies House Nummer: 08918100 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Matthews of Chester Holdings LTD Status: Aktiv Eintragung: 23.05.2023 Companies House Nummer: 10953077 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors as trust
  • gb-flag GB Chamonix Holdings Limited Status: Inaktiv Eintragung: 02.12.2020 Löschung: 31.05.2023 Companies House Nummer: 12500321 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB R.C. Housing Limited Status: Inaktiv Eintragung: 13.10.2017 Löschung: 31.05.2023 Companies House Nummer: 11012025 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors