UID-Suche.at

UID-Suche


Alle Informationen zu:

                        
Name

CMT Print London Limited

Adresse
Unit 3, The Triton Centre
Premier Way
Romsey
Hampshire
SO51 9DJ
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
Beginn der Umsatzsteuer Registrierung
27. Oktober 2019
Firmenbuch-Nummer 12119876 Companies House Eintrag ansehen
FB Status aktiv
Gründungsdatum24. Juli 2019
JahresabschlussGROUP
nächster Jahresabschluss fällig bis 30. Juni 2024
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2022
Branche (ÖNACE)70100 - Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben
KYC Check
KYC / PEP / AML-Abfrage
Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

Quelle: Companies House
gb-flag GB Tcm Packaging Limited Status: Aktiv Eintragung: 29.09.2023 Companies House Nummer: 15152030 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • Burton, Christopher Status: Inaktiv Eintragung: 24.07.2019 Löschung: 28.09.2023 Geburtsdatum: 01.1983 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%
  • Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
  • Manser, Michelle Karen Status: Inaktiv Eintragung: 24.07.2019 Löschung: 28.09.2023 Geburtsdatum: 03.1980 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%
  • Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
  • Manser, Thomas Anthony Status: Inaktiv Eintragung: 24.07.2019 Löschung: 28.09.2023 Geburtsdatum: 05.1982 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%
  • Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
  • gb-flag GB Tcm Print London Limited Status: Inaktiv Eintragung: 28.09.2023 Löschung: 29.09.2023 Companies House Nummer: 15152029 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • Officers (5)

    Quelle: Companies House
    Burton, Christopher Romsey, England Status: Aktiv Eintragung: 24.07.2019 Geburtsdatum: 01.1983 Beschäftigung: Chief Executive Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Manser, Anthony Romsey, England Status: Aktiv Eintragung: 09.10.2019 Geburtsdatum: 06.1957 Beschäftigung: Chairman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Manser, Michelle Karen Romsey, England Status: Aktiv Eintragung: 24.07.2019 Geburtsdatum: 03.1980 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Manser, Thomas Anthony Romsey, England Status: Aktiv Eintragung: 24.07.2019 Geburtsdatum: 05.1982 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Martin, Colan Paul Romsey, England Status: Aktiv Eintragung: 09.10.2019 Geburtsdatum: 04.1966 Beschäftigung: Chartered Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

    Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)

    gb-flag Cedar Packaging Limited Status: Aktiv Eintragung: 28.09.2023 Companies House Nummer: 08333422 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag Cedar London Limited Status: Inaktiv Eintragung: 09.10.2019 Löschung: 28.09.2023 Companies House Nummer: 05524310 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more