UID-Suche.at

UID-Suche


Alle Informationen zu:

                        
Name

Firstport Property Services NO.8 Limited

Adresse
23-24 Market Place
Reading
RG1 2DE
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
Beginn der Umsatzsteuer Registrierung
26. Juni 2023
Ende der Umsatzsteuer Registrierung
13. Jänner 2024
FB Adresse Fifth Floor The Lantern
New Milton
NW1 2PL
Firmenbuch-Nummer 06805193 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschlussaudit-exemption-subsidiary
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)68320 - Verwaltung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte
FB Statusactive
Vorherige Namen
  • Atlantis Estates LTD
  • KYC Check
    KYC / PEP / AML-Abfrage
    Diese Daten sind inkorrekt?
    Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

    Schnellzugriff

    Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

    Quelle: Companies House
    gb-flag GB Firstport Group Limited Status: Aktiv Eintragung: 31.05.2023 Companies House Nummer: 04352396 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB Atlantis Estates Limited Status: Inaktiv Eintragung: 31.03.2019 Löschung: 31.05.2023 Companies House Nummer: 09586423 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Sykes, John Jac Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 31.03.2019 Geburtsdatum: 06.1971 Art der Kontrolle
  • Significant influence or control
  • Officers (4)

    Quelle: Companies House
    Firstport Secretarial Limited, New Milton, Hampshire, England Status: Aktiv Eintragung: 20.06.2022 Rolle: Secretary
    Keenan, John Joseph 75 Hampstead Road, London, England Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2024 Beschäftigung: Chief Financial Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Perrett, Steve John 75 Hampstead Road, London, England Status: Aktiv Eintragung: 27.06.2022 Geburtsdatum: 04.1965 Beschäftigung: Estates Finance Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Saleh, Ouda 75 Hampstead Road, London, England Status: Aktiv Eintragung: 20.06.2022 Geburtsdatum: 01.1979 Beschäftigung: Director Of Finance Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

    Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (10)

    gb-flag GB Aspect Mews Residents Management Company Limited Status: Aktiv Eintragung: 21.05.2018 Companies House Nummer: 09409281 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • gb-flag GB De Havilland Orchard Residents Management Company Limited Status: Aktiv Eintragung: 20.11.2018 Companies House Nummer: 10457987 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • gb-flag GB Earls Garden Management Company Limited Status: Aktiv Eintragung: 03.05.2018 Companies House Nummer: 08973284 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • gb-flag GB Mortimers Gate Residents Management Company LTD Status: Aktiv Eintragung: 25.10.2018 Companies House Nummer: 10711891 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • gb-flag GB Oaks Meadow Management Company LTD Status: Aktiv Eintragung: 02.04.2020 Companies House Nummer: 12544544 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • gb-flag GB The Oaks Residents Management Company LTD Status: Aktiv Eintragung: 20.11.2018 Companies House Nummer: 09847710 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • gb-flag GB Thurmans Grove Residents Management Company Limited Status: Aktiv Eintragung: 17.12.2019 Companies House Nummer: 10524367 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • gb-flag GB Cobmead Management Company LTD Status: Inaktiv Eintragung: 27.11.2019 Löschung: 01.01.2023 Companies House Nummer: 11239384 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • gb-flag GB Marham Park (Bury ST Edmunds) Management Company Limited Status: Inaktiv Eintragung: 17.08.2017 Löschung: 22.08.2024 Companies House Nummer: 10921074 Art der Kontrolle
  • Significant influence or control
  • gb-flag GB Oakwood Hill (Halstead) Management Company Limited Status: Inaktiv Eintragung: 01.05.2018 Löschung: 25.02.2025 Companies House Nummer: 11338130 Art der Kontrolle
  • Significant influence or control