UID-Suche.at

UID-Suche


Alle Informationen zu:

                        
Name

Computer Associates UK LTD

Adresse
Fourth Floor
Abbots House
Abbey Street
Reading, Berkshire
RG1 3BD
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
Beginn der Umsatzsteuer Registrierung
12. April 2018
FB Name Computer Associates UK Limited
Firmenbuch-Nummer 03696244 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschlussfull
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Oktober 2022
Branche (ÖNACE)62020 - Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie
FB Statusactive
Vorherige Namen
  • Computer Associates UK LTD | CA Technologies
  • Computer Associates UK LTD CA Technologies
  • KYC Check
    KYC / PEP / AML-Abfrage
    Diese Daten sind inkorrekt?
    Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

    Schnellzugriff

    Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

    Quelle: Companies House
    gb-flag GB Ca Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 01282495 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • Officers (2)

    Quelle: Companies House
    Brazeal, Mark David San Jose, California, United States Status: Aktiv Eintragung: 14.07.2020 Geburtsdatum: 01.1968 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American
    Spears, Kirsten Margreta San Jose, California, United States Status: Aktiv Eintragung: 01.05.2019 Geburtsdatum: 02.1964 Beschäftigung: Finance Professional Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

    Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

    gb-flag GB CA Technology R&D Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 07251836 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors