UID-Suche.at

UID-Suche


Alle Informationen zu:

                        
Name

Edocuments LTD

Adresse
Unit 32
Waterhouse Business Centre
Chelmsford
Essex
CM1 2QE
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
FB Name Edocuments Limited
FB Adresse Swift House, Ground Floor
Essex
CM1 1GU
Firmenbuch-Nummer 04236508 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschlusstotal-exemption-full
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2022
Branche (ÖNACE)82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
FB Statusactive
KYC Check
KYC / PEP / AML-Abfrage
Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House
gb-flag GB Glider Technology Holdings Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.09.2024 Companies House Nummer: 15476995 Art der Kontrolle
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • Right to appoint and remove directors
  • Dupee, James David Status: Inaktiv Eintragung: 22.07.2024 Löschung: 06.09.2024 Geburtsdatum: 09.1972 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%
  • Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
  • Morgan, Lester John Status: Inaktiv Eintragung: 19.06.2016 Löschung: 06.09.2024 Geburtsdatum: 05.1965 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%
  • Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
  • Reynolds, Christopher Status: Inaktiv Eintragung: 19.06.2016 Löschung: 06.09.2024 Geburtsdatum: 05.1972 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%
  • Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
  • Officers (6)

    Quelle: Companies House
    Hutchinson, Nicholas John Brighton, England Status: Aktiv Eintragung: 06.09.2024 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Dupee, James David Danbury, Chelmsford Status: Inaktiv Eintragung: 01.01.2003 Löschung: 06.09.2024 Geburtsdatum: 09.1972 Beschäftigung: Applications Development Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Groves, Daniel Peter Chelmsford, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 18.10.2021 Löschung: 06.09.2024 Geburtsdatum: 11.1978 Beschäftigung: Software Designer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British
    Morgan, Lester John Great Baddow, Chelmsford Status: Inaktiv Eintragung: 18.06.2001 Löschung: 06.09.2024 Geburtsdatum: 05.1965 Beschäftigung: Facilities Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Reynolds, Christopher South Hanningfield Road, Rettendon Common, Chelmsford Status: Inaktiv Eintragung: 05.04.2007 Löschung: 06.09.2024 Geburtsdatum: 05.1972 Beschäftigung: Operations Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British
    Reynolds, Christopher South Hanningfield Road, Rettendon Common, Chelmsford Status: Inaktiv Eintragung: 30.10.2007 Löschung: 06.09.2024 Beschäftigung: Secretary & Opperations Direct Rolle: Secretary Nationalität: British

    Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)

    gb-flag GB Temporary Limited Status: Aktiv Eintragung: 01.01.2020 Companies House Nummer: 05089167 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more
  • gb-flag GB Temporary Limited Status: Aktiv Eintragung: 01.01.2020 Companies House Nummer: 05089167 Art der Kontrolle
  • Ownership of shares - 75% or more
  • Ownership of voting rights - 75% or more